-
ECOKEG EUROPE LIMITED - Unit 2c St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate, Brynmenyn, Bridgend, Mid Glamorgan, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09045224
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 2c St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate
- Brynmenyn
- Bridgend
- Mid Glamorgan
- CF32 9TZ Unit 2c St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate, Brynmenyn, Bridgend, Mid Glamorgan, CF32 9TZ UK
Management
- Geschäftsführung
- THOMAS, Keith
- TIPPLES, Stephen Vaughan
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-19 10 Jahre
- SIC/NACE
- 22290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Keith Thomas
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-03-31
- Letzte Einreichung: 2022-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-06-02
- Letzte Einreichung: 2022-05-19
-
ECOKEG EUROPE LIMITED Firmenbeschreibung
- ECOKEG EUROPE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09045224. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22290" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 2C St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate erreicht werden.
Jetzt sichern ECOKEG EUROPE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ecokeg Europe Limited - Unit 2c St. Theodores Way, Brynmenyn Industrial Estate, Brynmenyn, Bridgend, Mid Glamorgan, Grossbritannien
- 2014-05-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ECOKEG EUROPE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-notice-compulsory (2023-06-06) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-06-30) - DISS40
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-03-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-08-04) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2022-08-09) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-08-10) - DISS40
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-07-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-31) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-01-04) - PSC01
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-08-23) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2019-08-23) - SH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-24) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-20) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-25) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-18) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-22) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-02-13) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-09) - PSC01
-
gazette-notice-compulsory (2017-08-08) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-03-28) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-08-12) - DISS40
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-26) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-05) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-12-29) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-12-21) - SH01
-
resolution (2015-12-21) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-11-18) - AA01
-
capital-allotment-shares (2015-08-12) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-04) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-19) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-03) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-22) - TM01