-
BEDE GAMING (HOLDINGS) LIMITED - Bevan House 1 Esh Plaza, Floor 2, Sir Bobby Robson Way, Newcastle Upon Tyne, NE13 9BA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09038323
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bevan House 1 Esh Plaza, Floor 2
- Sir Bobby Robson Way
- Newcastle Upon Tyne
- NE13 9BA
- England Bevan House 1 Esh Plaza, Floor 2, Sir Bobby Robson Way, Newcastle Upon Tyne, NE13 9BA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BRADY, Michael James
- BUTCHER, Alexander Francis
- DOUGAL, John James
- SAUMAREZ SMITH, Joseph William
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-13 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62012
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Falcon Topco Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-27
- Letzte Einreichung: 2021-05-13
-
BEDE GAMING (HOLDINGS) LIMITED Firmenbeschreibung
- BEDE GAMING (HOLDINGS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09038323. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62012" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Bevan House 1 Esh Plaza, Floor 2 erreicht werden.
Jetzt sichern BEDE GAMING (HOLDINGS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Bede Gaming (Holdings) Limited - Bevan House 1 Esh Plaza, Floor 2, Sir Bobby Robson Way, Newcastle Upon Tyne, NE13 9BA, Grossbritannien
- 2014-05-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu BEDE GAMING (HOLDINGS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-09-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-03-26) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-08) - TM01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-08) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-10-06) - AA
-
capital-allotment-shares (2020-04-08) - SH01
-
memorandum-articles (2020-04-22) - MA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-21) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-21) - PSC02
-
resolution (2020-04-22) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-06-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
capital-allotment-shares (2019-01-22) - SH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-01-30) - RP04SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-17) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-01) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-28) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-10-02) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-03) - PSC04
-
capital-allotment-shares (2019-12-18) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
capital-allotment-shares (2018-04-24) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-16) - CH01
-
capital-allotment-shares (2018-05-18) - SH01
-
capital-allotment-shares (2018-07-09) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-09-13) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-19) - AP01
-
capital-allotment-shares (2018-10-18) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-18) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-16) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-10-02) - AA
-
capital-allotment-shares (2017-04-21) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-23) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-02-10) - SH01
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2017-03-09) - RP04AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-10) - TM01
-
capital-allotment-shares (2017-04-03) - SH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2017-03-09) - RP04SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-05-10) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-04-21) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-04) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-09-29) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-09-25) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-25) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-19) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-19) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-02-24) - SH01
-
resolution (2015-02-24) - RESOLUTIONS
-
change-constitution-enactment (2015-02-24) - CC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-06-29) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-08-21) - AA01
-
incorporation-company (2014-05-13) - NEWINC