-
TOTAL E&P AKTOBE LIMITED - 19th Floor 10 Upper Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5BF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09034996
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 19th Floor 10 Upper Bank Street
- Canary Wharf
- London
- E14 5BF
- England 19th Floor 10 Upper Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5BF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DECUBBER, Stephane Michel Jean Francois
- ANDRIES, Karen Cecilia
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 06100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Totalenergies Se
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- MAERSK OIL KAZAKHSTAN E&P LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2025-04-18
- Letzte Einreichung: 2024-04-04
-
TOTAL E&P AKTOBE LIMITED Firmenbeschreibung
- TOTAL E&P AKTOBE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09034996. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.05.2014 registriert. TOTAL E&P AKTOBE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MAERSK OIL KAZAKHSTAN E&P LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "06100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 19Th Floor 10 Upper Bank Street erreicht werden.
Jetzt sichern TOTAL E&P AKTOBE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Total E&p Aktobe Limited - 19th Floor 10 Upper Bank Street, Canary Wharf, London, E14 5BF, Grossbritannien
- 2014-05-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu TOTAL E&P AKTOBE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-04-20) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2024-04-20) - PSC07
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-04-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2024-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-22) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-04-04) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-04-26) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-07-27) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-08-28) - PSC05
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-10-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-26) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-05-12) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-26) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-10-07) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-11-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-07) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-11) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-02) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-07-06) - CH01
-
resolution (2018-06-29) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-25) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-20) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-20) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-16) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-06-10) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-10-25) - TM01
-
capital-allotment-shares (2016-01-13) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-06) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-11-28) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-01) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-07-06) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-07) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-21) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-01) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-04-30) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-01) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-01) - TM01
-
capital-allotment-shares (2015-03-02) - SH01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-01-28) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-12) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name (2014-06-09) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-09) - AP01