-
ESTURA PROPERTIES LIMITED - Unit 1 First Floor Brook Business Centre, Cowley Mill Road, Uxbridge, UB8 2FX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09033108
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 1 First Floor Brook Business Centre
- Cowley Mill Road
- Uxbridge
- UB8 2FX Unit 1 First Floor Brook Business Centre, Cowley Mill Road, Uxbridge, UB8 2FX UK
Management
- Geschäftsführung
- BATEMAN, Stuart Andrew
- ROBBINS, David Francis
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-09 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Nicolas James Holdings Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-23
- Letzte Einreichung: 2021-05-09
-
ESTURA PROPERTIES LIMITED Firmenbeschreibung
- ESTURA PROPERTIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09033108. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 1 First Floor Brook Business Centre erreicht werden.
Jetzt sichern ESTURA PROPERTIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Estura Properties Limited - Unit 1 First Floor Brook Business Centre, Cowley Mill Road, Uxbridge, UB8 2FX, Grossbritannien
- 2014-05-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ESTURA PROPERTIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-07-05) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-07-21) - AD01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-07-21) - PSC05
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-11-04) - AD01
-
resolution (2021-11-05) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-11-05) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-11-05) - LIQ01
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-05-26) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-25) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-05-26) - TM02
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-31) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-07-10) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-10) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-07-10) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-11) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-19) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-05-02) - AA01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2018-01-11) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-10) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-01-09) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-12) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-01) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-01) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-06-01) - CH03
-
accounts-with-accounts-type-small (2016-06-06) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-09) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-29) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-06-22) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-06-22) - CH03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-07-07) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-29) - MR01
-
incorporation-company (2014-05-09) - NEWINC