-
MFCOIL LIMITED - Unit 8 Wharfside, Rosemont Road, Wembley, HA0 4PE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09033010
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 8 Wharfside
- Rosemont Road
- Wembley
- HA0 4PE
- England Unit 8 Wharfside, Rosemont Road, Wembley, HA0 4PE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FOSSEY, Sebastian
- HICKEY, Paul
- MCGEE, John Paul
- MCGEE, Thomas James
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 09.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-09 10 Jahre
- SIC/NACE
- 42990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- MCGEE CONSTRUCTION GROUP UK LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-08-31
- Letzte Einreichung: 2020-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-23
- Letzte Einreichung: 2021-05-09
-
MFCOIL LIMITED Firmenbeschreibung
- MFCOIL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09033010. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 09.05.2014 registriert. MFCOIL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MCGEE CONSTRUCTION GROUP UK LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "42990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 8 Wharfside erreicht werden.
Jetzt sichern MFCOIL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Mfcoil Limited - Unit 8 Wharfside, Rosemont Road, Wembley, HA0 4PE, Grossbritannien
- 2014-05-09
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MFCOIL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-group (2021-09-04) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-07-19) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-05-18) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-17) - CS01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2021-03-19) - RP04SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-05-12) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-05-12) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-12) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-06-15) - AD01
-
capital-allotment-shares (2020-07-29) - SH01
-
memorandum-articles (2020-08-10) - MA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-09-02) - TM01
-
resolution (2020-08-10) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-09-03) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-12-03) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-08-16) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-08-16) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-05-15) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-15) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-15) - PSC04
-
resolution (2018-02-05) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-01-16) - SH03
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-02-27) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-02-27) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-06-19) - AA
-
capital-return-purchase-own-shares (2017-03-20) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2017-03-20) - SH06
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-09) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-05-16) - CH01
-
capital-cancellation-shares (2017-01-16) - SH06
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-08-20) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
capital-allotment-shares (2015-11-24) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-11-12) - MR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-11-10) - AA01
-
certificate-change-of-name-company (2015-11-10) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-11-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-11-09) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-14) - AR01
-
resolution (2015-11-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-09) - NEWINC