-
HUNTSHAW LTD - Centenary House Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09027779
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Centenary House Peninsula Park
- Rydon Lane
- Exeter
- EX2 7XE
- United Kingdom Centenary House Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- COBB, David John
- DALE, William David John
- VARLEY, John Christian
- WILDING, William John
- Prokuristen
- VANSTONE, Graham Edward
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-07 10 Jahre
- SIC/NACE
- 64209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr David James Roper Robinson
- Michael Trefusis Chamberlayne Lvo
- Mr Noel George Herbert Manns
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-05-21
- Letzte Einreichung: 2023-05-07
-
HUNTSHAW LTD Firmenbeschreibung
- HUNTSHAW LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09027779. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64209" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Centenary House Peninsula Park erreicht werden.
Jetzt sichern HUNTSHAW LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Huntshaw Ltd - Centenary House Peninsula Park, Rydon Lane, Exeter, EX2 7XE, Grossbritannien
- 2014-05-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HUNTSHAW LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-09-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-03-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-03-08) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-09-08) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2023-07-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-05-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2022-07-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-05-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-05-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2021-08-06) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2020-09-01) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-03) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-14) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-08-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-07-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-04-13) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-19) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2017-08-03) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-17) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-01-20) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-01-20) - TM02
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-11) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-01) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-06-17) - SH01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-05-23) - AA01
-
incorporation-company (2014-05-07) - NEWINC