-
HYDRO ENERGY TRADING LIMITED - Beeston Lodge Beeston Lane, Spixworth, Norwich, NR10 3TN, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09026478
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Beeston Lodge Beeston Lane
- Spixworth
- Norwich
- NR10 3TN
- England Beeston Lodge Beeston Lane, Spixworth, Norwich, NR10 3TN, England UK
Management
- Geschäftsführung
- FOSTER, Roy Neil
- KING, Malcolm Anthony Wallace, Dr
- FOSTER, Martin Creassey
- PARRACK, Ian
- TURNER, Alan Gerard
- Prokuristen
- EXTERNAL OFFICER LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.05.2014
- Alter der Firma 2014-05-06 10 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Scottish Hydro Investment Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-16
- Letzte Einreichung: 2021-02-02
-
HYDRO ENERGY TRADING LIMITED Firmenbeschreibung
- HYDRO ENERGY TRADING LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09026478. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 06.05.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Beeston Lodge Beeston Lane erreicht werden.
Jetzt sichern HYDRO ENERGY TRADING LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hydro Energy Trading Limited - Beeston Lodge Beeston Lane, Spixworth, Norwich, NR10 3TN, Grossbritannien
- 2014-05-06
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HYDRO ENERGY TRADING LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-06-17) - AA
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-04-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-02) - CS01
-
resolution (2021-06-30) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2021-06-30) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-06-28) - MR01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-06-21) - PSC05
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-06-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-06-21) - AP01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2021-02-02) - RP04SH01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-name-of-class-of-shares (2020-03-12) - SH08
-
resolution (2020-03-11) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-01-05) - AA
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2020-03-12) - SH10
-
resolution (2020-08-12) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-05-06) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-07-27) - SH01
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-12-03) - CH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-06-20) - PSC02
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-06-20) - PSC09
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-17) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-04-12) - SH01
-
second-filing-capital-allotment-shares (2019-06-11) - RP04SH01
-
resolution (2019-05-08) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-02-19) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-02-22) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-08) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-05) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-05-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-06) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-20) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-27) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-14) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-09-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-10) - CS01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2017-09-14) - AP04
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-29) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-08) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-22) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-11-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-28) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-05-19) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2015-05-19) - SH02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-12) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-12) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-12) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-12) - AD01
-
resolution (2015-11-16) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-05-06) - NEWINC