-
EMERALD MIDCO 2 LIMITED - Mandeville House, 62 The Broadway, Amersham, Buckinghamshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 09019593
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Mandeville House
- 62 The Broadway
- Amersham
- Buckinghamshire
- HP7 0HJ Mandeville House, 62 The Broadway, Amersham, Buckinghamshire, HP7 0HJ UK
Management
- Geschäftsführung
- JOHNSON, Anthony David
- MCNEILL, John
- ROY, Karen Jane
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 30.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-30 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Emerald Midco 1 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- DE FACTO 2112 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-05-08
- Letzte Einreichung: 2021-04-24
-
EMERALD MIDCO 2 LIMITED Firmenbeschreibung
- EMERALD MIDCO 2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 09019593. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 30.04.2014 registriert. EMERALD MIDCO 2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen DE FACTO 2112 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Mandeville House erreicht werden.
Jetzt sichern EMERALD MIDCO 2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Emerald Midco 2 Limited - Mandeville House, 62 The Broadway, Amersham, Buckinghamshire, Grossbritannien
- 2014-04-30
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EMERALD MIDCO 2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
legacy (2022-01-10) - GUARANTEE2
-
legacy (2022-01-10) - AGREEMENT2
-
legacy (2022-01-10) - PARENT_ACC
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2022-01-10) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2021-11-10) - MR01
-
legacy (2021-11-01) - GUARANTEE2
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
capital-allotment-shares (2020-01-17) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-01-14) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-04-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-12-20) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-10-03) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-06-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-05) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-10-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-05-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-01-13) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-02-02) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-05-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-25) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-12-20) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-05-11) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-22) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-03) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-21) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-05-01) - AA
-
second-filing-of-form-with-form-type (2015-05-05) - RP04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-25) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-04-30) - NEWINC
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-29) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2014-07-03) - CERTNM
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-10) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-07-15) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-15) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-07-29) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-07-23) - TM02
-
resolution (2014-07-29) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-07-29) - SH01
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-07-29) - SH10
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-29) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-07-29) - AA01