-
4SYTE CONSTRUCTION LIMITED - Second Floor Steeple House, Church Lane, Chelmsford, Essex, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08980337
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Second Floor Steeple House
- Church Lane
- Chelmsford
- Essex
- CM1 1NH
- England Second Floor Steeple House, Church Lane, Chelmsford, Essex, CM1 1NH, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BARKER, Paul Michael
- GUNDERSEN, Magnus Ingolf
- SELLARS, Nick
- WILSON, Samantha
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-07 10 Jahre
- SIC/NACE
- 64992
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Wayne Shore
- -
- 4syte Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- CIRRUS 4SYTE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-07
- Letzte Einreichung: 2023-06-23
-
4SYTE CONSTRUCTION LIMITED Firmenbeschreibung
- 4SYTE CONSTRUCTION LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08980337. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 07.04.2014 registriert. 4SYTE CONSTRUCTION LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CIRRUS 4SYTE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64992" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Second Floor Steeple House erreicht werden.
Jetzt sichern 4SYTE CONSTRUCTION LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 4Syte Construction Limited - Second Floor Steeple House, Church Lane, Chelmsford, Essex, Grossbritannien
- 2014-04-07
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 4SYTE CONSTRUCTION LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-06-24) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-04-20) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-06-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-09) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-06-26) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-02-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-01-21) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-04-15) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-25) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-10) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-03) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-05-03) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-29) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-09-17) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-19) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-06) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-12-06) - TM01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-12-17) - PSC02
-
capital-allotment-shares (2018-12-17) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-12-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-06-21) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-04) - AA
-
resolution (2017-07-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-06-28) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-06-21) - TM01
-
resolution (2017-06-19) - RESOLUTIONS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-06-17) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-20) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-15) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-22) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-11-04) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-01) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-17) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-23) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-29) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-08-28) - AP03
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-08-21) - MR01
-
incorporation-company (2014-04-07) - NEWINC