-
HETHERTONS SOLICITORS LIMITED - Tudor Court Opus Avenue, York Business Park, York, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08977176
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Tudor Court Opus Avenue
- York Business Park
- York
- North Yorkshire
- YO26 6RS Tudor Court Opus Avenue, York Business Park, York, North Yorkshire, YO26 6RS UK
Management
- Geschäftsführung
- HALLAM, David Charles
- HENRY, Thomas St.John
- ROBINSON, Philip John
- CORPS, Anthony John
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.04.2014
- Alter der Firma 2014-04-03 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Thomas St.John Henry
- -
- Mr David Charles Hallam
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-22
- Letzte Einreichung: 2023-09-08
-
HETHERTONS SOLICITORS LIMITED Firmenbeschreibung
- HETHERTONS SOLICITORS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08977176. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.04.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Tudor Court Opus Avenue erreicht werden.
Jetzt sichern HETHERTONS SOLICITORS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hethertons Solicitors Limited - Tudor Court Opus Avenue, York Business Park, York, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2014-04-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HETHERTONS SOLICITORS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-09-20) - AP01
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2023-01-30) - RP04TM01
-
capital-allotment-shares (2023-02-03) - SH01
-
capital-allotment-shares (2023-02-14) - SH01
-
resolution (2023-06-26) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2023-02-17) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2023-08-14) - SH06
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-07-18) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-07-25) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-09-08) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2023-09-08) - PSC07
-
capital-allotment-shares (2023-09-08) - SH01
-
second-filing-of-director-termination-with-name (2023-08-21) - RP04TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2023-09-27) - SH03
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-07-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-updates (2022-12-09) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-12-12) - PSC01
-
capital-return-purchase-own-shares (2022-12-12) - SH03
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-12-09) - PSC01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-04-04) - CS01
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2022-12-09) - PSC09
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-12-09) - TM01
-
capital-cancellation-shares (2022-11-01) - SH06
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-10) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-04) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-13) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-05-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-28) - AA
-
second-filing-of-annual-return-with-made-up-date (2017-04-24) - RP04AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-04-13) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2016-04-06) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-04-21) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-12-23) - AA
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2015-12-23) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-23) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-07) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-12-13) - MR01
-
incorporation-company (2014-04-03) - NEWINC