-
LIVING SPACE CONSTRUCTION (HERTS) LIMITED - 5 Mercia Business Village, Torwood Close, Coventry, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08962178
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Mercia Business Village
- Torwood Close
- Coventry
- West Midlands
- CV4 8HX 5 Mercia Business Village, Torwood Close, Coventry, West Midlands, CV4 8HX UK
Management
- Geschäftsführung
- BURDETT, Christopher Robert
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 43290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Christopher Robert Burdett
- Mrs Zoe Michelle Burdett
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-03-29
- Letzte Einreichung: 2019-03-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-05-08
- Letzte Einreichung: 2020-03-27
-
LIVING SPACE CONSTRUCTION (HERTS) LIMITED Firmenbeschreibung
- LIVING SPACE CONSTRUCTION (HERTS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08962178. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "43290" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 5 Mercia Business Village erreicht werden.
Jetzt sichern LIVING SPACE CONSTRUCTION (HERTS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Living Space Construction (Herts) Limited - 5 Mercia Business Village, Torwood Close, Coventry, West Midlands, Grossbritannien
- 2014-03-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu LIVING SPACE CONSTRUCTION (HERTS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2023-03-30) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-10-20) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-04-15) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-19) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-03-27) - 600
-
resolution (2021-03-27) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-03-27) - LIQ02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-06-03) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-04-02) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-04-02) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-04-02) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-03-05) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-03-29) - PSC04
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-30) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-29) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-31) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-29) - AD01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-06) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-31) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-28) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-02) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-01-22) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-06) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-29) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-06-14) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2017-06-13) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-06) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-12) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-20) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-20) - AD01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-22) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-05-09) - CH01
-
incorporation-company (2014-03-27) - NEWINC