-
ANOTHER9 (U.K.) LIMITED - C/O Ekco Reading Limited, Merlin House Brunel Road, Theale, Reading, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08951091
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Ekco Reading Limited, Merlin House Brunel Road
- Theale
- Reading
- Berkshire
- RG7 4AB
- England C/O Ekco Reading Limited, Merlin House Brunel Road, Theale, Reading, Berkshire, RG7 4AB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BLACKLOCK, Eoin
- BRADLEY, Adam Stephen
- O'REILLY, David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 20.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-20 10 Jahre
- SIC/NACE
- 62030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Denis O'Brien
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-03
- Letzte Einreichung: 2021-03-20
-
ANOTHER9 (U.K.) LIMITED Firmenbeschreibung
- ANOTHER9 (U.K.) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08951091. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 20.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "62030" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Ekco Reading Limited, Merlin House Brunel Road erreicht werden.
Jetzt sichern ANOTHER9 (U.K.) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Another9 (U.k.) Limited - C/O Ekco Reading Limited, Merlin House Brunel Road, Theale, Reading, Berkshire, Grossbritannien
- 2014-03-20
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ANOTHER9 (U.K.) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
accounts-with-accounts-type-audited-abridged (2021-09-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-31) - CS01
-
memorandum-articles (2021-01-04) - MA
-
resolution (2021-01-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-22) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-23) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-12-23) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-09-21) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-22) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2020-12-22) - PSC08
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-22) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-12-22) - PSC07
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2019-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2018-10-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-22) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-02-27) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-03-02) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2017-12-05) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-11-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-02-02) - TM01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-12-06) - DISS40
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2017-03-04) - DISS40
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2017-01-10) - DISS16(SOAS)
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-24) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-11) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-01-11) - TM02
-
gazette-notice-compulsory (2016-12-06) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-08) - AA01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-08-20) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-08-20) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-09) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-02) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2015-04-01) - CH03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-04-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-23) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-03-20) - NEWINC