-
JSM (UK) LTD - 11 St. Albans Road, Gloucester, GL2 5FW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08938109
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 11 St. Albans Road
- Gloucester
- GL2 5FW
- England 11 St. Albans Road, Gloucester, GL2 5FW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- GRIFFITHS, Andrew John
- GRIFFITHS, Anthony
- GRIFFITHS, Grace Miriam
- GRIFFITHS, Samuel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 13.03.2014
- Alter der Firma 2014-03-13 10 Jahre
- SIC/NACE
- 47990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Jsm Innovations Group Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800R59VLBROMI3P16
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-02-29
- Letzte Einreichung: 2022-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-03-27
- Letzte Einreichung: 2023-03-13
-
JSM (UK) LTD Firmenbeschreibung
- JSM (UK) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08938109. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 13.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "47990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 11 St. Albans Road erreicht werden.
Jetzt sichern JSM (UK) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jsm (Uk) Ltd - 11 St. Albans Road, Gloucester, GL2 5FW, England, Grossbritannien
- 2014-03-13
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JSM (UK) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-02-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2023-03-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-08-18) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-08-18) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-02-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-03-17) - CS01
-
resolution (2022-03-26) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2022-03-26) - MA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-15) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-22) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-18) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-02-25) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-19) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-12-11) - MR04
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-02-21) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-15) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-15) - PSC04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-15) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-02-28) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-22) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-28) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-02-16) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-02-16) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-30) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-09-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-09-09) - MR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2015-09-07) - SH08
-
capital-allotment-shares (2015-09-07) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-13) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-07-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-19) - AP01
-
incorporation-company (2014-03-13) - NEWINC