-
FLISCOMBE POWER LIMITED - Dairy Farm Office Dairy Road, Semer, Ipswich, IP7 6RA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08922467
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Dairy Farm Office Dairy Road
- Semer
- Ipswich
- IP7 6RA
- England Dairy Farm Office Dairy Road, Semer, Ipswich, IP7 6RA, England UK
Management
- Geschäftsführung
- COURSE, Charles Paul
- MILES, Hannah Lucy
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.03.2014
- Gelöscht am:
- 2021-01-26
- SIC/NACE
- 38210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Heathpatch Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-07-31
- Letzte Einreichung: 2019-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-04-21
- Letzte Einreichung: 2020-03-10
-
FLISCOMBE POWER LIMITED Firmenbeschreibung
- FLISCOMBE POWER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08922467. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 04.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "38210" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Dairy Farm Office Dairy Road erreicht werden.
Jetzt sichern FLISCOMBE POWER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fliscombe Power Limited - Dairy Farm Office Dairy Road, Semer, Ipswich, IP7 6RA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FLISCOMBE POWER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-10-30) - DS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-03-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-30) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-05-28) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-03-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-02-21) - AA
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-12) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-01-02) - TM02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-01-03) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-25) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-26) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2018-03-28) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-11-19) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-25) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-25) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-13) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-28) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-12-21) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-18) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-11-07) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-11-07) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-11-07) - MR01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-07) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-03) - CH01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2016-06-01) - CH03
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-05-24) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2016-05-19) - TM02
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-23) - AR01
-
change-corporate-director-company-with-change-date (2016-08-23) - CH02
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-04) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-05-05) - TM02
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-05-05) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-20) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-corporate-director-company-with-name (2014-04-01) - AP02
-
resolution (2014-04-23) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-05-07) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-15) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-15) - TM01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-09) - MR01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-11-13) - SH08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-06) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-06) - AP01
-
resolution (2014-11-13) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-15) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-10-22) - AA01
-
incorporation-company (2014-03-04) - NEWINC