-
SIPLAS LIMITED - 2nd Floor 39 Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08920211
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 2nd Floor 39 Bore Street
- Lichfield
- Staffordshire
- WS13 6LZ 2nd Floor 39 Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LZ UK
Management
- Geschäftsführung
- GRAY, Derick
- GRAY, Gaynor Andrea
- GRAY, Stephen John
- SIMMS, Edwin Michael Christopher
- WARD, Eric Stuart
- Prokuristen
- WARD, Eric Stuart
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.03.2014
- Gelöscht am:
- 2024-02-17
- SIC/NACE
- 22290
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Derick Gray
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-01-31
- Letzte Einreichung: 2016-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2018-03-17
- Letzte Einreichung: 2017-03-03
-
SIPLAS LIMITED Firmenbeschreibung
- SIPLAS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08920211. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 03.03.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "22290" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 2Nd Floor 39 Bore Street erreicht werden.
Jetzt sichern SIPLAS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Siplas Limited - 2nd Floor 39 Bore Street, Lichfield, Staffordshire, WS13 6LZ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SIPLAS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
gazette-dissolved-liquidation (2024-02-17) - GAZ2
keyboard_arrow_right 2023
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2023-11-06) - AD01
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-11-17) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-11-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-12-07) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-07-23) - LIQ10
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-18) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-07-23) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-12-08) - LIQ03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-08-03) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-10-24) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-establishment-of-creditors-or-liquidation-committee (2018-01-26) - COM1
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-11-21) - LIQ03
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-09-04) - MR04
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2018-05-18) - LIQ10
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-01-16) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-03) - MR01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-10-20) - LIQ02
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-07) - CS01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-10-23) - 600
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-10-23) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-27) - AD01
-
resolution (2017-10-23) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
resolution (2016-10-04) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2016-10-11) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-07) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-02-24) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-24) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-10-29) - MR04
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-09-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-04-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-28) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-06-04) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-05) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-06-10) - MR01
-
legacy (2014-06-07) - MG06
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-08-20) - AA01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-11-24) - TM02
-
resolution (2014-06-05) - RESOLUTIONS
-
incorporation-company (2014-03-03) - NEWINC