-
ELECTRIC GLUE LIMITED - 62 Dean Street, London, W1D 4QF, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08900707
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 62 Dean Street
- London
- W1D 4QF
- England 62 Dean Street, London, W1D 4QF, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWN, Kevin Thomas
- HEDEN, Tim
- KARBASSIOUN, Darius
- KENDALL, Nicholas John
- ORPIN, Simon John
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-18 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70210
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Simon Orpin
- Mr Simon Orpin
- Mr Kevin Thomas Brown
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- ALL SCREENS 21 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-02-28
- Letzte Einreichung: 2020-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-07-09
- Letzte Einreichung: 2021-06-25
-
ELECTRIC GLUE LIMITED Firmenbeschreibung
- ELECTRIC GLUE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08900707. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.02.2014 registriert. ELECTRIC GLUE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ALL SCREENS 21 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70210" registriert. Das Unternehmen hat 5 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 62 Dean Street erreicht werden.
Jetzt sichern ELECTRIC GLUE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Electric Glue Limited - 62 Dean Street, London, W1D 4QF, England, Grossbritannien
- 2014-02-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ELECTRIC GLUE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-07-01) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-07-01) - PSC01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-07) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-06-12) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-26) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-10-16) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-08) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-07-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-12-19) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-06-28) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-04-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-02-28) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-02-15) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-03-30) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-31) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-20) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-05-21) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-09) - AP01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-12-13) - SH02
-
capital-cancellation-shares (2016-12-14) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2016-07-18) - SH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-12-05) - AD01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-05-24) - DISS40
-
capital-allotment-shares (2016-03-30) - SH01
-
gazette-notice-compulsory (2016-05-17) - GAZ1
-
resolution (2016-03-30) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-01-14) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-12-17) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-30) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-04-16) - SH01
-
resolution (2015-03-26) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-02-27) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-04) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name (2014-03-04) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-04) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-04) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2014-09-17) - CERTNM
-
capital-allotment-shares (2014-03-07) - SH01
-
change-of-name-notice (2014-09-17) - CONNOT
-
incorporation-company (2014-02-18) - NEWINC
-
resolution (2014-03-06) - RESOLUTIONS