-
FAIRBRIAR REAL ESTATE LIMITED - Europa House, 20 Esplanade, Scarborough, North Yorkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08891830
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Europa House
- 20 Esplanade
- Scarborough
- North Yorkshire
- YO11 2AQ Europa House, 20 Esplanade, Scarborough, North Yorkshire, YO11 2AQ UK
Management
- Geschäftsführung
- TUTTON, Jeremy John
- ZAIFENG, Mi
- KELLY, Paul Michael
- YIP, Hoong Mun
- Prokuristen
- ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 64203
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Scarborough Finance Company Limited
- Scarborough Premier Developments Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SCARBOROUGH REAL ESTATE LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-26
- Letzte Einreichung: 2021-02-12
-
FAIRBRIAR REAL ESTATE LIMITED Firmenbeschreibung
- FAIRBRIAR REAL ESTATE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08891830. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.02.2014 registriert. FAIRBRIAR REAL ESTATE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SCARBOROUGH REAL ESTATE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "64203" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Europa House erreicht werden.
Jetzt sichern FAIRBRIAR REAL ESTATE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fairbriar Real Estate Limited - Europa House, 20 Esplanade, Scarborough, North Yorkshire, Grossbritannien
- 2014-02-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FAIRBRIAR REAL ESTATE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-25) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-04-08) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-09-11) - PSC05
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-06-22) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-06-19) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-04-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-04-15) - PSC07
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-03-26) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-09-23) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2020-04-15) - PSC02
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-02-18) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-group (2019-09-19) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-04-17) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-03-16) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-08-31) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-04-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-12) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-22) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-03-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-06-16) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-07-01) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2015
-
memorandum-articles (2015-11-11) - MA
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-03-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-09) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-10-08) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-29) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-29) - AP01
-
incorporation-company (2014-02-12) - NEWINC
-
certificate-change-of-name-company (2014-02-26) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-03-03) - AA01
-
capital-allotment-shares (2014-08-07) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-08-13) - SH01
-
resolution (2014-08-13) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-08-13) - SH08
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-08-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-21) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2014-08-28) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-05) - AP01