-
O-TEAS LIMITED - Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08888580
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Kemp House
- 152 City Road
- London
- EC1V 2NX Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX UK
Management
- Geschäftsführung
- EVANS, David Neil
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 28930
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paresh Thakkar
- David Evans
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- JYMEC LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-01-31
- Letzte Einreichung: 2021-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-24
- Letzte Einreichung: 2021-09-10
-
O-TEAS LIMITED Firmenbeschreibung
- O-TEAS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08888580. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.02.2014 registriert. O-TEAS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen JYMEC LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "28930" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Kemp House erreicht werden.
Jetzt sichern O-TEAS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: O-Teas Limited - Kemp House, 152 City Road, London, EC1V 2NX, Grossbritannien
- 2014-02-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu O-TEAS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-12-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-10-05) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-02-26) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-02-25) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-07-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-07-23) - TM01
-
capital-allotment-shares (2020-02-12) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-11-13) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2020-10-09) - CS01
-
resolution (2020-07-28) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-18) - AA
-
capital-allotment-shares (2019-10-07) - SH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-07) - CS01
-
capital-allotment-shares (2019-10-01) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-12-19) - MR01
keyboard_arrow_right 2018
-
resolution (2018-02-12) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2018-02-15) - SH01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-25) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-25) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-11-07) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-18) - CS01
-
capital-allotment-shares (2017-09-29) - SH01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-01) - AP01
-
capital-allotment-shares (2016-10-18) - SH01
-
resolution (2016-10-18) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-10-25) - SH02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-03-04) - MR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2016-05-31) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-08) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-11-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-11-11) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-15) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-14) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-03) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-07-23) - AP01
-
termination-director-company (2015-05-14) - TM01
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-12) - CERTNM
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-05-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-05-11) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-05-01) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-03-05) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-07-23) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
incorporation-company (2014-02-12) - NEWINC