-
JASCOTS WINE MERCHANTS LIMITED - Third Floor, One London Square, Cross Lanes, Guildford, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08887662
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Third Floor
- One London Square
- Cross Lanes
- Guildford
- GU1 1UN Third Floor, One London Square, Cross Lanes, Guildford, GU1 1UN UK
Management
- Geschäftsführung
- CARTER, Ian James
- CHARNOCK, John Simon
- MACINNES, Miles Thomas
- SCOTT, Jonathan James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.02.2014
- Alter der Firma 2014-02-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 46342
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr John Simon Charnock
- Mr Miles Thomas Macinnes
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- administration
- Ehemalige Namen
- CANDENE LIMITED
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800BOGNN9WLDJB802
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-04-30
- Letzte Einreichung: 2019-04-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-09-18
- Letzte Einreichung: 2020-09-04
-
JASCOTS WINE MERCHANTS LIMITED Firmenbeschreibung
- JASCOTS WINE MERCHANTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08887662. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.02.2014 registriert. JASCOTS WINE MERCHANTS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen CANDENE LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46342" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Third Floor erreicht werden.
Jetzt sichern JASCOTS WINE MERCHANTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Jascots Wine Merchants Limited - Third Floor, One London Square, Cross Lanes, Guildford, Grossbritannien
- 2014-02-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu JASCOTS WINE MERCHANTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-12-04) - AA
-
memorandum-articles (2018-04-30) - MA
-
resolution (2018-04-30) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2018-04-23) - SH03
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-10) - CS01
-
resolution (2018-04-06) - RESOLUTIONS
-
capital-cancellation-shares (2018-04-06) - SH06
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-05-22) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-06-05) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-08-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-10-13) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-30) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-11-06) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-05) - CS01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-02) - CS01
-
resolution (2016-04-27) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-26) - TM01
-
capital-alter-shares-subdivision (2016-04-26) - SH02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-04-11) - MR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-29) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-08) - AR01
-
auditors-resignation-company (2016-04-27) - AUD
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-03) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-02-17) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-02-24) - AP03
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-03-17) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-02-17) - AP01
-
capital-allotment-shares (2015-04-30) - SH01
-
change-of-name-notice (2015-05-01) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2015-05-01) - CERTNM
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-22) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-03-25) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-24) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-20) - AD01
-
incorporation-company (2014-02-12) - NEWINC