-
CASTLEGATE 715 LIMITED - Ernst & Young Llp, 1 Colmore Square, Birmingham, B4 6HQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08858846
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Ernst & Young Llp
- 1 Colmore Square
- Birmingham
- B4 6HQ Ernst & Young Llp, 1 Colmore Square, Birmingham, B4 6HQ UK
Management
- Geschäftsführung
- CROCKFORD, Thomas Leslie
- ELLIOTT, Jonathan David
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.01.2014
- Gelöscht am:
- 2022-04-28
- SIC/NACE
- 63990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul Isaacs
- Bionic Services Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-02-06
- Letzte Einreichung: 2021-01-23
-
CASTLEGATE 715 LIMITED Firmenbeschreibung
- CASTLEGATE 715 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08858846. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "63990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Ernst & Young Llp erreicht werden.
Jetzt sichern CASTLEGATE 715 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Castlegate 715 Limited - Ernst & Young Llp, 1 Colmore Square, Birmingham, B4 6HQ, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CASTLEGATE 715 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2021-04-12) - LIQ01
-
resolution (2021-04-07) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-audit-exemption-subsiduary (2021-03-17) - AA
-
legacy (2021-03-17) - PARENT_ACC
-
legacy (2021-03-17) - AGREEMENT2
-
legacy (2021-03-17) - GUARANTEE2
-
confirmation-statement-with-updates (2021-02-09) - CS01
-
legacy (2021-01-11) - SH20
-
legacy (2021-01-11) - CAP-SS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2021-01-11) - SH19
-
resolution (2021-01-11) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-04-07) - 600
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-04-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-19) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-02-19) - PSC05
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-05-17) - TM01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-05-17) - MR04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-05-17) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-05-17) - PSC02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-05-17) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-20) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2019-07-08) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-09) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-07) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-28) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-01-03) - TM02
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2017-09-28) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-15) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-03-11) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-03-09) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-03-09) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-28) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-01-06) - TM01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-09-11) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-15) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-10) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2014-03-12) - SH10
-
memorandum-articles (2014-03-24) - MEM/ARTS
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-03-12) - SH08
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-03-12) - SH02
-
capital-allotment-shares (2014-03-12) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-11) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-05) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-05) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2014-03-05) - TM01
-
incorporation-company (2014-01-23) - NEWINC
-
resolution (2014-03-12) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-13) - AP01