-
DPGOC LTD - Unit 1, Willow Row, Longton, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08848623
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 1, Willow Row
- Longton
- Stoke On Trent
- Staffordshire
- ST3 2PU
- United Kingdom Unit 1, Willow Row, Longton, Stoke On Trent, Staffordshire, ST3 2PU, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CIUPEK, Brett Anderson
- CIUPEK, Heath Barclay
- MACHIN, Adele Louise
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 16.01.2014
- Alter der Firma 2014-01-16 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Christine Ciupek
- Mr Brett Anderson Ciupek
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-11-30
- Letzte Einreichung: 2020-02-29
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-02-27
- Letzte Einreichung: 2020-01-16
-
DPGOC LTD Firmenbeschreibung
- DPGOC LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08848623. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 16.01.2014 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 1, Willow Row erreicht werden.
Jetzt sichern DPGOC LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Dpgoc Ltd - Unit 1, Willow Row, Longton, Stoke On Trent, Staffordshire, Grossbritannien
- 2014-01-16
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu DPGOC LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
capital-cancellation-shares (2021-02-11) - SH06
-
capital-return-purchase-own-shares (2021-02-11) - SH03
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-08-26) - TM01
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-03-03) - SH03
-
capital-cancellation-shares (2020-02-24) - SH06
-
confirmation-statement-with-updates (2020-02-10) - CS01
-
capital-cancellation-shares (2020-01-22) - SH06
-
resolution (2020-01-21) - RESOLUTIONS
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-01-21) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-11-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-02-09) - PSC01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-02-09) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-11) - PSC07
-
capital-name-of-class-of-shares (2019-03-20) - SH08
-
resolution (2019-03-22) - RESOLUTIONS
-
capital-variation-of-rights-attached-to-shares (2019-03-20) - SH10
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-08-14) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-01-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-03) - AA
-
legacy (2018-10-04) - RP04CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-02-28) - AD01
-
legacy (2018-01-19) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-01-18) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-01-18) - PSC07
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-12-18) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-24) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-01-09) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-31) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-09) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-29) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-02-17) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-04) - AD01
-
capital-allotment-shares (2014-08-01) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-12) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2014-09-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-21) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-10-21) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-11-25) - AP01
-
incorporation-company (2014-01-16) - NEWINC