-
ST JAMES' CENTRAL LIMITED - Picton Manor, Ellison Place, Newcastle Upon Tyne, NE1 8XG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08831704
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Picton Manor
- Ellison Place
- Newcastle Upon Tyne
- NE1 8XG
- United Kingdom Picton Manor, Ellison Place, Newcastle Upon Tyne, NE1 8XG, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CLEMENT, Paul
- KALBRAIER, Robert William
- PESTELL, Paul David
- Prokuristen
- KALBRAIER, Victoria Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 03.01.2014
- Alter der Firma 2014-01-03 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Robert William Kalbraier
- -
- Mr Paul David Pestell
- Mr Paul Clement
- Mr. Paul Clement
- Mr Paul Clement
- Tyneside Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- TYNESIDE CENTRAL DEVELOPMENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-09-30
- Letzte Einreichung: 2018-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-12-06
- Letzte Einreichung: 2019-10-25
-
ST JAMES' CENTRAL LIMITED Firmenbeschreibung
- ST JAMES' CENTRAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08831704. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 03.01.2014 registriert. ST JAMES' CENTRAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TYNESIDE CENTRAL DEVELOPMENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Picton Manor erreicht werden.
Jetzt sichern ST JAMES' CENTRAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: St James' Central Limited - Picton Manor, Ellison Place, Newcastle Upon Tyne, NE1 8XG, Grossbritannien
- 2014-01-03
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu ST JAMES' CENTRAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-notice-voluntary (2020-10-27) - GAZ1(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-10-19) - DS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-07-12) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-07-12) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-07-08) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-21) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-25) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-07-24) - PSC07
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-03) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-24) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-06-22) - AD02
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2016-11-22) - AD04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-11-01) - AD01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-06-22) - AD03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-22) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-06-21) - CH01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-18) - MR04
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-27) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-06-22) - AP03
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-17) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-23) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-08) - AD01
-
certificate-change-of-name-company (2014-01-08) - CERTNM
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2014-01-10) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-10) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-22) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-24) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-26) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-06-09) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-23) - AP01
-
incorporation-company (2014-01-03) - NEWINC