-
STEMCOR FRANCE LIMITED - Longbow House, 14-20 Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08820259
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Longbow House
- 14-20 Chiswell Street
- London
- EC1Y 4TW
- England Longbow House, 14-20 Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- CHECKETTS, Andrew John
- GRAF, Steven Mitchell
- VERDEN, Julian
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-19 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Stemcor Holdings 2 Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-01-27
- Letzte Einreichung: 2023-01-13
-
STEMCOR FRANCE LIMITED Firmenbeschreibung
- STEMCOR FRANCE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08820259. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.12.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Longbow House erreicht werden.
Jetzt sichern STEMCOR FRANCE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Stemcor France Limited - Longbow House, 14-20 Chiswell Street, London, EC1Y 4TW, Grossbritannien
- 2013-12-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu STEMCOR FRANCE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-09-18) - AA
-
accounts-amended-with-accounts-type-full (2023-10-05) - AAMD
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-04-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-01-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-01-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2021-05-07) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-01-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-07-17) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-05-24) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-05-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-01-02) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-01-26) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2018-01-02) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-02-22) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-15) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-05) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-05-29) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-12-17) - MR04
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-03-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-16) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-27) - PSC05
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-07-18) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-06) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-03-24) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-23) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-21) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-03-09) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-01) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-14) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-01-12) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
resolution (2015-10-06) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-20) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-23) - MR01
-
memorandum-articles (2015-10-06) - MA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-01-07) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-19) - AR01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-18) - TM02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-24) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-21) - MR01
-
memorandum-articles (2014-03-20) - MEM/ARTS
-
resolution (2014-03-20) - RESOLUTIONS
-
memorandum-articles (2014-01-24) - MEM/ARTS
-
resolution (2014-01-24) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-19) - NEWINC