-
FULCRUM POWER LIMITED - 3rd Floor, 141-145 Curtain Road, London, EC2A 3BX, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08811059
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 3rd Floor, 141-145 Curtain Road
- London
- EC2A 3BX
- England 3rd Floor, 141-145 Curtain Road, London, EC2A 3BX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BEYNON, Paul Roderick
- CHAMBERLAYNE, Robin Francis
- NEWMAN, Andrew
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 11.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-11 10 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-01-22
- Letzte Einreichung: 2019-12-11
-
FULCRUM POWER LIMITED Firmenbeschreibung
- FULCRUM POWER LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08811059. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 11.12.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 3Rd Floor, 141-145 Curtain Road erreicht werden.
Jetzt sichern FULCRUM POWER LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Fulcrum Power Limited - 3rd Floor, 141-145 Curtain Road, London, EC2A 3BX, England, Grossbritannien
- 2013-12-11
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu FULCRUM POWER LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
legacy (2020-12-15) - CAP-SS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-04-15) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-09-16) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-12-16) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-12-16) - AP01
-
capital-return-purchase-own-shares (2020-12-16) - SH03
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-12-03) - AA
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-12-15) - SH19
-
memorandum-articles (2020-12-15) - MA
-
legacy (2020-12-15) - SH20
-
capital-cancellation-shares (2020-12-15) - SH06
-
resolution (2020-12-15) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-09-27) - AA
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-02-25) - CH01
-
second-filing-of-director-appointment-with-name (2019-01-29) - RP04AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-24) - CS01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2018-12-15) - DISS40
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-12-13) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2018-12-11) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-06) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-11) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-05) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-05) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-09-16) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-09-11) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-08-19) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-04) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-11-03) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-23) - AD01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-01-08) - SH08
-
capital-allotment-shares (2014-02-27) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2014-02-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-06) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-27) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-10) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-13) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-03-19) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-03-24) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-31) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-05-09) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-09-17) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-12) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-06-23) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-12-24) - RESOLUTIONS
-
termination-secretary-company-with-name (2013-12-20) - TM02
-
incorporation-company (2013-12-11) - NEWINC