-
SAFARI KID CHISWICK LIMITED - Oakmoore Court Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08804472
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Oakmoore Court Kingswood Road
- Hampton Lovett
- Droitwich
- Worcestershire
- WR9 0QH
- United Kingdom Oakmoore Court Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, WR9 0QH, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- SACHS, Philippe Eric
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 06.12.2013
- Gelöscht am:
- 2020-10-06
- SIC/NACE
- 85100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Verde Education Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- MODERN DAY NURSERY LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
-
SAFARI KID CHISWICK LIMITED Firmenbeschreibung
- SAFARI KID CHISWICK LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08804472. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 06.12.2013 registriert. SAFARI KID CHISWICK LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen MODERN DAY NURSERY LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "85100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Oakmoore Court Kingswood Road erreicht werden.
Jetzt sichern SAFARI KID CHISWICK LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Safari Kid Chiswick Limited - Oakmoore Court Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich, Worcestershire, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SAFARI KID CHISWICK LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-voluntary (2020-10-06) - GAZ2(A)
-
dissolution-application-strike-off-company (2020-04-14) - DS01
-
gazette-notice-voluntary (2020-04-21) - GAZ1(A)
keyboard_arrow_right 2019
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-30) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-26) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-06-25) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-05-28) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-01-18) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-06-21) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-06-21) - PSC02
-
change-of-name-notice (2018-08-24) - CONNOT
-
resolution (2018-08-24) - RESOLUTIONS
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-08-31) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-10) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-08-31) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-21) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-12-13) - AA01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-12-18) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-12-18) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-08-31) - AD01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-25) - PSC02
-
mortgage-satisfy-charge-full (2018-06-14) - MR04
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-23) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-03) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-01-15) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-02-10) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-12) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-04-27) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-02-10) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-12-30) - SH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-30) - CH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-30) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-30) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-04-28) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-06) - NEWINC