-
SHOO 592 LIMITED - Stone Hall Park Lane, Brook, Godalming, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08801946
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Stone Hall Park Lane
- Brook
- Godalming
- Surrey
- GU8 5LA Stone Hall Park Lane, Brook, Godalming, Surrey, GU8 5LA UK
Management
- Geschäftsführung
- CHESTERMAN, Edward John
- LINFIELD, Paul Stephen
- VENEIK, Rekha Kumari
- Prokuristen
- CHESTERMAN, Katherine Jane
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 04.12.2013
- Alter der Firma 2013-12-04 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Edward John Chesterman
- Mr Paul Stephen Linfield
- Mrs Rekha Kumari Veneik
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-12-18
- Letzte Einreichung: 2023-12-04
-
SHOO 592 LIMITED Firmenbeschreibung
- SHOO 592 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08801946. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 04.12.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Stone Hall Park Lane erreicht werden.
Jetzt sichern SHOO 592 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Shoo 592 Limited - Stone Hall Park Lane, Brook, Godalming, Surrey, Grossbritannien
- 2013-12-04
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SHOO 592 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
confirmation-statement-with-no-updates (2024-01-15) - CS01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-01-10) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-09-29) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-09-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-20) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-12-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-27) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-12-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-02-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-30) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-02-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-12-06) - AA
-
gazette-notice-compulsory (2015-12-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-05-23) - DISS40
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-05-20) - AR01
-
gazette-notice-compulsory (2015-04-14) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-12-08) - DISS40
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-07-29) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-07-23) - AP01
-
capital-allotment-shares (2014-07-18) - SH01
-
termination-director-company-with-name (2014-06-24) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-24) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-06-24) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-06-24) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2014-06-24) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-12-04) - NEWINC