-
HTA REALISATIONS LIMITED - C/O Frp Advosory Llp Ashcroft House Ervington Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08791960
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Frp Advosory Llp Ashcroft House Ervington Court
- Meridian Business Park
- Leicester
- LE19 1WL C/O Frp Advosory Llp Ashcroft House Ervington Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL UK
Management
- Geschäftsführung
- HUMAN, David Lorne
- HYLAND, Phil Julian Paul
- WAKEFORD, Richard Francis
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.11.2013
- Alter der Firma 2013-11-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 86900
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Human Touch Health Ltd
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Ehemalige Namen
- HUMAN TOUCH AMBULANCE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2017-08-31
- Letzte Einreichung: 2015-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2017-12-11
- Letzte Einreichung: 2016-11-27
-
HTA REALISATIONS LIMITED Firmenbeschreibung
- HTA REALISATIONS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08791960. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.11.2013 registriert. HTA REALISATIONS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HUMAN TOUCH AMBULANCE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "86900" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2015 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über C/o Frp Advosory Llp Ashcroft House Ervington Court erreicht werden.
Jetzt sichern HTA REALISATIONS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hta Realisations Limited - C/O Frp Advosory Llp Ashcroft House Ervington Court, Meridian Business Park, Leicester, LE19 1WL, Grossbritannien
- 2013-11-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HTA REALISATIONS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2021-09-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-04-24) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-removal-of-liquidator-by-court (2020-05-14) - LIQ10
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-08) - LIQ03
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-05-14) - 600
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-09-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2018-10-04) - LIQ03
-
liquidation-disclaimer-notice (2018-10-02) - NDISC
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-10-02) - RESOLUTIONS
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2017-08-30) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-11) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2017-08-10) - 600
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-05-12) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-13) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-07) - TM01
-
change-of-name-notice (2017-10-02) - CONNOT
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-17) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-06) - TM01
-
second-filing-of-form-with-form-type-made-up-date (2016-04-24) - RP04
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-01-28) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2016-01-28) - AD02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-17) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-03-18) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-02-25) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-10) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-10-16) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-16) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-11-14) - MR04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-07-15) - AD01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-05-13) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-04-02) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-11-27) - NEWINC