-
HURACAN HOLDINGS LIMITED - Halton View Villas, 3-5 Wilson Patten Street, Warrington, WA1 1PG, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08790261
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Halton View Villas
- 3-5 Wilson Patten Street
- Warrington
- WA1 1PG
- England Halton View Villas, 3-5 Wilson Patten Street, Warrington, WA1 1PG, England UK
Management
- Geschäftsführung
- BUTT, Nasir Mahmood
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.11.2013
- Alter der Firma 2013-11-26 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68209
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Miss Sennah Mahmood
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SMILE STUDENTS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-08-31
- Letzte Einreichung: 2021-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-02-19
- Letzte Einreichung: 2022-02-05
-
HURACAN HOLDINGS LIMITED Firmenbeschreibung
- HURACAN HOLDINGS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08790261. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.11.2013 registriert. HURACAN HOLDINGS LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SMILE STUDENTS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68209" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Halton View Villas erreicht werden.
Jetzt sichern HURACAN HOLDINGS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Huracan Holdings Limited - Halton View Villas, 3-5 Wilson Patten Street, Warrington, WA1 1PG, Grossbritannien
- 2013-11-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HURACAN HOLDINGS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-02-14) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2023-02-14) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-02-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2022-11-30) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-05-01) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-04-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-01-06) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-10-07) - MR04
-
gazette-notice-compulsory (2021-11-02) - GAZ1
-
dissolved-compulsory-strike-off-suspended (2021-12-09) - DISS16(SOAS)
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2021-12-14) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2021-12-15) - DISS40
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-02-05) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-30) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2019-11-27) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-11-02) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2019-10-29) - GAZ1
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-04-30) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-04-30) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-04-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-08-31) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-11) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-04-11) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-12-04) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-04-11) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-19) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-03-19) - AP01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-19) - PSC01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-19) - TM01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-11-27) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-09-28) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-03-04) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-08) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-06-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-27) - AP01
-
gazette-notice-compulsory (2016-11-01) - GAZ1
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-11-02) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-11-01) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-08-18) - AA
-
capital-allotment-shares (2015-08-17) - SH01
keyboard_arrow_right 2014
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-21) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-15) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-11-26) - NEWINC