-
VIRTUOSO LEGAL LIMITED - 1st Floor 5 Sheepscar Court, Northside Business Park, Leeds, LS7 2BB, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08767694
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 1st Floor 5 Sheepscar Court
- Northside Business Park
- Leeds
- LS7 2BB
- England 1st Floor 5 Sheepscar Court, Northside Business Park, Leeds, LS7 2BB, England UK
Management
- Geschäftsführung
- RAWNSLEY, Elaine Ann
- WARD, Elizabeth Margaret
- Prokuristen
- RAWNSLEY, Elaine Ann
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.11.2013
- Alter der Firma 2013-11-08 10 Jahre
- SIC/NACE
- 69102
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Ms Elizabeth Margaret Ward
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-06-28
- Letzte Einreichung: 2020-09-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-10-14
- Letzte Einreichung: 2021-09-30
-
VIRTUOSO LEGAL LIMITED Firmenbeschreibung
- VIRTUOSO LEGAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08767694. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 08.11.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "69102" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 1St Floor 5 Sheepscar Court erreicht werden.
Jetzt sichern VIRTUOSO LEGAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Virtuoso Legal Limited - 1st Floor 5 Sheepscar Court, Northside Business Park, Leeds, LS7 2BB, Grossbritannien
- 2013-11-08
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VIRTUOSO LEGAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2022-02-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-01-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-01-17) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-14) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-09-22) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2020-11-26) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-08) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2020-09-17) - AA01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-20) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2019-06-15) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-04-04) - AP03
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2018-06-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-25) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-04-11) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-31) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-11-20) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-01-18) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-12-19) - AA01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-21) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-05-24) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-04-20) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-04-19) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-04-05) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-02-26) - MR04
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-02-02) - CH01
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-03-25) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-03-27) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-13) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-11-13) - AP01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-10-27) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-02) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-11) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-07-28) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-11-08) - NEWINC