-
MAGNATECH TECHNOLOGY LIMITED - Gable House 239 Regents Park Road, Finchley, London, N3 3LF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08762659
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Gable House 239 Regents Park Road
- Finchley
- London
- N3 3LF Gable House 239 Regents Park Road, Finchley, London, N3 3LF UK
Management
- Geschäftsführung
- HOLLAND, Sarah
- YOUNG, Clive Anthony
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 05.11.2013
- Alter der Firma 2013-11-05 10 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Simon David Goodchild
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- ELLENESSE LTD
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-08-31
- Letzte Einreichung: 2022-11-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-11-19
- Letzte Einreichung: 2022-11-05
-
MAGNATECH TECHNOLOGY LIMITED Firmenbeschreibung
- MAGNATECH TECHNOLOGY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08762659. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 05.11.2013 registriert. MAGNATECH TECHNOLOGY LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ELLENESSE LTD ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.11.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Gable House 239 Regents Park Road erreicht werden.
Jetzt sichern MAGNATECH TECHNOLOGY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Magnatech Technology Limited - Gable House 239 Regents Park Road, Finchley, London, N3 3LF, Grossbritannien
- 2013-11-05
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MAGNATECH TECHNOLOGY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-06-05) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-06-12) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2023-08-10) - AP01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-to-a-person-with-significant-control (2022-09-27) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-09-27) - PSC07
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2022-09-27) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-21) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2022-02-28) - TM01
keyboard_arrow_right 2021
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-04-21) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-12) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-11-20) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2021-12-17) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2021-12-17) - CH01
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-updates (2020-11-26) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-04-07) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-01-02) - PSC04
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2020-01-02) - CH03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-10-30) - PSC04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-28) - TM01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-01-28) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-28) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-01-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-01-18) - TM01
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-10-30) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-06) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-09-12) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-11-14) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-27) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-11-14) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-08-22) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-27) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-18) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-15) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-27) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-21) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-12-05) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-19) - MR01
-
termination-director-company-with-name (2014-01-13) - TM01
keyboard_arrow_right 2013
-
certificate-change-of-name-company (2013-12-17) - CERTNM
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-12) - AP01
-
termination-director-company-with-name (2013-12-11) - TM01
-
capital-allotment-shares (2013-12-11) - SH01
-
incorporation-company (2013-11-05) - NEWINC
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-12-11) - AP01