-
MEMORIA - AMBER VALLEY MEMORIAL PARK LTD - The Pool House Bicester Road, Stratton Audley, Bicester, Oxfordshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08749441
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- The Pool House Bicester Road
- Stratton Audley
- Bicester
- Oxfordshire
- OX27 9BS
- United Kingdom The Pool House Bicester Road, Stratton Audley, Bicester, Oxfordshire, OX27 9BS, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- ESSE, Anthony Geoffrey David
- HODGSON, Howard Osmond Paul
- HODGSON, Jamieson Charles Alexandre Howard
- PENNEY, Christopher James Affleck
- Prokuristen
- WEAVER, Randi
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 25.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-25 10 Jahre
- SIC/NACE
- 96030
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Howard Osmond Paul Hodgson
- -
- Mr Michael Anthony Hackney
- Memoria Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-09-30
- Letzte Einreichung: 2019-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-11-08
- Letzte Einreichung: 2020-10-25
-
MEMORIA - AMBER VALLEY MEMORIAL PARK LTD Firmenbeschreibung
- MEMORIA - AMBER VALLEY MEMORIAL PARK LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08749441. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 25.10.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "96030" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über The Pool House Bicester Road erreicht werden.
Jetzt sichern MEMORIA - AMBER VALLEY MEMORIAL PARK LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Memoria - Amber Valley Memorial Park Ltd - The Pool House Bicester Road, Stratton Audley, Bicester, Oxfordshire, Grossbritannien
- 2013-10-25
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu MEMORIA - AMBER VALLEY MEMORIAL PARK LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
resolution (2021-06-07) - RESOLUTIONS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-01-29) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-01-29) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-05-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-26) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2021-05-21) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-21) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-05-21) - AD01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2021-05-21) - TM02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-12-31) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-12-23) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-17) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-11-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-06-01) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-26) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-08) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-06-01) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-06-21) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2017-07-26) - AA
-
memorandum-articles (2017-07-11) - MA
-
resolution (2017-07-11) - RESOLUTIONS
-
resolution (2017-06-27) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-11-14) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-11-08) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-unaudited-abridged (2016-09-30) - AA
-
legacy (2016-03-03) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2016-03-03) - SH19
-
legacy (2016-03-03) - CAP-SS
-
resolution (2016-03-03) - RESOLUTIONS
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2016-12-22) - AP04
keyboard_arrow_right 2015
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-06-03) - AA01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-05-07) - CH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-18) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-10-09) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-26) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-23) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-05-13) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-03-26) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2014-03-19) - SH02
-
resolution (2014-03-19) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-25) - NEWINC