-
THORNTON MOTORS SERVICES (PEMBROKESHIRE) LIMITED - Unit 16 Thornton Industrial Trading Estate, Milford Haven, Pembrokeshire, SA73 2RR, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08747155
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 16 Thornton Industrial Trading Estate
- Milford Haven
- Pembrokeshire
- SA73 2RR
- United Kingdom Unit 16 Thornton Industrial Trading Estate, Milford Haven, Pembrokeshire, SA73 2RR, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- GOFFIN, Justin
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-24 10 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Mr Justin Goffin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2025-07-30
- Letzte Einreichung: 2023-10-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-11-07
- Letzte Einreichung: 2023-10-24
-
THORNTON MOTORS SERVICES (PEMBROKESHIRE) LIMITED Firmenbeschreibung
- THORNTON MOTORS SERVICES (PEMBROKESHIRE) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08747155. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 24.10.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Unit 16 Thornton Industrial Trading Estate erreicht werden.
Jetzt sichern THORNTON MOTORS SERVICES (PEMBROKESHIRE) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Thornton Motors Services (Pembrokeshire) Limited - Unit 16 Thornton Industrial Trading Estate, Milford Haven, Pembrokeshire, SA73 2RR, Grossbritannien
- 2013-10-24
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THORNTON MOTORS SERVICES (PEMBROKESHIRE) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2024-07-30) - AA
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-10-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2023-07-31) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-12-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-19) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-07-30) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-06-29) - CS01
-
liquidation-voluntary-arrangement-completion (2021-02-24) - CVA4
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-27) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2020-05-11) - CVA3
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-11-13) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-06-24) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2019-05-07) - CVA3
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-04-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2018-05-01) - CVA3
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-30) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-30) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-30) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-04-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-05-17) - AD01
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2017-05-03) - 1.3
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-27) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-04-04) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-10) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-07-29) - AA
-
liquidation-cva-supervisors-abstract-of-receipts-payments-with-brought-down-date (2016-06-07) - 1.3
-
liquidation-voluntary-arrangement-meeting-approving-companies-voluntary-arrangement (2016-06-07) - 1.1
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-17) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-24) - NEWINC