-
HAVISHAM HOMES LIMITED - Prince Albert House, 20 King Street, Maidenhead, Berkshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08745227
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Prince Albert House
- 20 King Street
- Maidenhead
- Berkshire
- SL6 1DT
- United Kingdom Prince Albert House, 20 King Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 1DT, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- BROWNLOW, David, Lord
- RAWSON, Benjamin James
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-23 10 Jahre
- SIC/NACE
- 68100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Havisham Developments Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- HAVISHAM DEVELOPMENTS SFS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-11-06
- Letzte Einreichung: 2021-10-23
-
HAVISHAM HOMES LIMITED Firmenbeschreibung
- HAVISHAM HOMES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08745227. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.10.2013 registriert. HAVISHAM HOMES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen HAVISHAM DEVELOPMENTS SFS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "68100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Prince Albert House erreicht werden.
Jetzt sichern HAVISHAM HOMES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Havisham Homes Limited - Prince Albert House, 20 King Street, Maidenhead, Berkshire, Grossbritannien
- 2013-10-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HAVISHAM HOMES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-updates (2021-11-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-03-11) - TM01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC05
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2020-03-11) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-01) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-12-04) - AA
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-12) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-updates (2018-11-01) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-10-31) - CH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-03-09) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-02-21) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-21) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-11-03) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-07-19) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-07) - CH01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-12-07) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-12-06) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-10-17) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-14) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-07-22) - TM01
-
resolution (2016-04-30) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-18) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-29) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-12-16) - AR01
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2015-03-07) - MR05
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-01-21) - AA01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-01-12) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
resolution (2014-01-28) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2014-01-28) - SH01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-01-28) - SH08
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-03-05) - MR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2014-12-22) - CH01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-10-23) - TM01
-
incorporation-company (2013-10-23) - NEWINC