-
IVORY PROJECTS LTD. - Hurst House High Street, Ripley, Woking, GU23 6AZ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08731660
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Hurst House High Street
- Ripley
- Woking
- GU23 6AZ
- England Hurst House High Street, Ripley, Woking, GU23 6AZ, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MOSER, Gabor
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.10.2013
- Alter der Firma 2013-10-14 10 Jahre
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Gabor Moser
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- IVORY HOMES SUNNINGHILL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-28
- Letzte Einreichung: 2023-10-14
-
IVORY PROJECTS LTD. Firmenbeschreibung
- IVORY PROJECTS LTD. ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08731660. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.10.2013 registriert. IVORY PROJECTS LTD. hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen IVORY HOMES SUNNINGHILL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Hurst House High Street erreicht werden.
Jetzt sichern IVORY PROJECTS LTD. HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ivory Projects Ltd. - Hurst House High Street, Ripley, Woking, GU23 6AZ, Grossbritannien
- 2013-10-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu IVORY PROJECTS LTD. aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
change-person-director-company-with-change-date (2023-10-28) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-28) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-10-30) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-18) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2023-10-10) - PSC04
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-10-20) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-01-18) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2021-09-29) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-10-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-14) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-17) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-12) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-16) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-06-05) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-03-02) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-02-28) - AA
-
resolution (2018-02-28) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-02) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-03-02) - AP03
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2017-01-12) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-12) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2016-05-19) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2016-12-05) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-31) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-17) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-04-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-30) - AR01
-
capital-allotment-shares (2014-10-30) - SH01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-08) - MR01
-
capital-allotment-shares (2014-09-08) - SH01
-
capital-allotment-shares (2014-04-03) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-14) - NEWINC
-
resolution (2013-12-17) - RESOLUTIONS
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-12-16) - SH02
-
resolution (2013-12-16) - RESOLUTIONS
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-29) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-11-18) - AA01