-
HRGT VANCOUVER HOLDCO (UK) LTD - C/O Quantuma Advisory Limited, High Holborn House, 52-54 High Holborn, London, WC1V 6RL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08727313
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Quantuma Advisory Limited
- High Holborn House, 52-54 High Holborn
- London
- WC1V 6RL C/O Quantuma Advisory Limited, High Holborn House, 52-54 High Holborn, London, WC1V 6RL UK
Management
- Geschäftsführung
- -
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 10.10.2013
- Gelöscht am:
- 2023-08-06
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Drc Capital Llp
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 213800AW51MTRH1TOG55
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-31
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-10-24
- Letzte Einreichung: 2020-10-10
-
HRGT VANCOUVER HOLDCO (UK) LTD Firmenbeschreibung
- HRGT VANCOUVER HOLDCO (UK) LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08727313. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 10.10.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Die Firma kann schriftlich über C/o Quantuma Advisory Limited erreicht werden.
Jetzt sichern HRGT VANCOUVER HOLDCO (UK) LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Hrgt Vancouver Holdco (Uk) Ltd - C/O Quantuma Advisory Limited, High Holborn House, 52-54 High Holborn, London, WC1V 6RL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu HRGT VANCOUVER HOLDCO (UK) LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
gazette-dissolved-liquidation (2023-08-06) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2023-05-06) - LIQ14
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2023-02-16) - TM01
keyboard_arrow_right 2022
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2022-04-02) - LIQ03
-
resolution (2022-04-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-12) - AD01
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2021-03-15) - LIQ02
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-03-15) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-group (2020-01-14) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-30) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-10-16) - PSC02
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-10-03) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-10-02) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-10-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-10-02) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2019-02-14) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-01-02) - TM02
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-group (2018-05-29) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-21) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-10) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-09-24) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-12-05) - MR01
-
resolution (2017-07-17) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-group (2017-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-10) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-04-04) - AP01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-12-06) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-04-10) - TM01
-
resolution (2017-12-07) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-06-14) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-12) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-07-31) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-01-05) - TM01
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-31) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-31) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-12-31) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-16) - AR01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-05-15) - AA01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-02-21) - AP03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-28) - AD01
-
resolution (2014-01-17) - RESOLUTIONS
-
resolution (2014-01-06) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-10-10) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-31) - MR01