-
GHG LONDON MANAGEMENT LIMITED - Allen House, 1 Westmead Road, Sutton, Surrey, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08723531
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Allen House
- 1 Westmead Road
- Sutton
- Surrey
- SM1 4LA Allen House, 1 Westmead Road, Sutton, Surrey, SM1 4LA UK
Management
- Geschäftsführung
- ACHENBAUM, Michael
- LEVINE, Jeffrey Elliot
- Prokuristen
- BANKS COOPER ASSOCIATES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 08.10.2013
- Gelöscht am:
- 2022-03-14
- SIC/NACE
- 55100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Michael Ashcroft
- Jeffrey Levine
- Mr Michael Achenbaum
- -
- Jeffrey Levine
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-12-29
- Letzte Einreichung: 2018-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-11-19
- Letzte Einreichung: 2019-10-08
-
GHG LONDON MANAGEMENT LIMITED Firmenbeschreibung
- GHG LONDON MANAGEMENT LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08723531. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 08.10.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "55100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über Allen House erreicht werden.
Jetzt sichern GHG LONDON MANAGEMENT LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ghg London Management Limited - Allen House, 1 Westmead Road, Sutton, Surrey, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GHG LONDON MANAGEMENT LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-creditors-return-of-final-meeting (2021-12-14) - LIQ14
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-full (2020-01-06) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-11-13) - MR04
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-12-14) - LIQ02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-12-16) - AD01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-12-14) - 600
-
resolution (2020-12-14) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-12-24) - AA01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-10-21) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-09-26) - AA01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2019-01-29) - PSC01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-01-29) - PSC07
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-06-12) - AD01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-07-13) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-07-13) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-10) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-09-27) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-22) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-10-16) - CH01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-09-21) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-13) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-31) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-08-31) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-24) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-04) - AR01
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-11-04) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-07-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
termination-secretary-company-with-name (2014-03-07) - TM02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2014-03-07) - AP04
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-03-07) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-05-08) - AD01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2014-05-08) - AA01
-
termination-director-company-with-name (2014-05-08) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-08-01) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-11-05) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-05-08) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
resolution (2013-11-07) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-06) - MR01
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name (2013-10-17) - AP04
-
termination-director-company-with-name (2013-10-17) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-17) - AP01
-
incorporation-company (2013-10-08) - NEWINC