-
J2 HYDRO LTD - Deepbridge House Honeycomb East, Chester Business Park, Chester, Cheshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08709619
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Deepbridge House Honeycomb East
- Chester Business Park
- Chester
- Cheshire
- CH4 9QN
- United Kingdom Deepbridge House Honeycomb East, Chester Business Park, Chester, Cheshire, CH4 9QN, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- EUGENI, Raymond Marc
- HUGHES, Andrew Morris
- Prokuristen
- HUGHES, Richard
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.09.2013
- Alter der Firma 2013-09-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Peter Robert Johnson
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2023-12-31
- Letzte Einreichung: 2022-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-10-11
- Letzte Einreichung: 2023-09-27
-
J2 HYDRO LTD Firmenbeschreibung
- J2 HYDRO LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08709619. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.09.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.10.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Deepbridge House Honeycomb East erreicht werden.
Jetzt sichern J2 HYDRO LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: J2 Hydro Ltd - Deepbridge House Honeycomb East, Chester Business Park, Chester, Cheshire, Grossbritannien
- 2013-09-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu J2 HYDRO LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-11-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-11-17) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-12-20) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2020-10-13) - AA01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-10-05) - RP04CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-31) - AA
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2020-10-07) - RP04CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-07) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-10-29) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-10-08) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2019-07-29) - AA01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-09) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-07-25) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-05-31) - PSC04
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-04) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-01-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-26) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-10-26) - AP01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2017-10-26) - AP03
-
withdrawal-of-a-person-with-significant-control-statement (2017-10-26) - PSC09
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-10-26) - PSC01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-10-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-02) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-17) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-23) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-12) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-03-17) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-09-08) - TM01
-
capital-allotment-shares (2014-08-06) - SH01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-13) - AP01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-11-05) - AA01
-
incorporation-company (2013-09-27) - NEWINC