-
THE R.T. FRENCH'S FOOD COMPANY LIMITED - 15 Canada Square, London, E14 5GL, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08701967
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 15 Canada Square
- London
- E14 5GL 15 Canada Square, London, E14 5GL UK
Management
- Geschäftsführung
- CREIGHTON, Laird Everett
- JINKS, Christopher
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.09.2013
- Gelöscht am:
- 2020-08-19
- SIC/NACE
- 46380
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mccormick (Uk) Limited
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Rechtsträger-Kennung (LEI)
- 5493007BCAFQVUN6KG52
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-09-30
- Letzte Einreichung: 2016-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2019-09-15
- Letzte Einreichung: 2018-09-01
-
THE R.T. FRENCH'S FOOD COMPANY LIMITED Firmenbeschreibung
- THE R.T. FRENCH'S FOOD COMPANY LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08701967. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 23.09.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "46380" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2016 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 15 Canada Square erreicht werden.
Jetzt sichern THE R.T. FRENCH'S FOOD COMPANY LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: The R.t. French's Food Company Limited - 15 Canada Square, London, E14 5GL, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu THE R.T. FRENCH'S FOOD COMPANY LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-08-19) - GAZ2
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-05-19) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2019-11-22) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-11-06) - AD01
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2018-10-05) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2018-10-05) - 600
-
resolution (2018-10-05) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-14) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-09-14) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-09-14) - AP01
keyboard_arrow_right 2017
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-08-30) - PSC02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-30) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-08-31) - AP01
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2017-10-05) - SH19
-
resolution (2017-10-05) - RESOLUTIONS
-
legacy (2017-10-05) - CAP-SS
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-08-30) - PSC07
-
legacy (2017-10-05) - SH20
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-10-07) - AA
-
resolution (2017-10-12) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-09-12) - CS01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-08-30) - TM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-08-30) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2017-07-18) - CH01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-11-11) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-11-10) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-13) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-09-08) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-23) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-20) - TM01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-05-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-09) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
gazette-notice-compulsory (2015-09-22) - GAZ1
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-09-30) - AR01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2015-10-03) - DISS40
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-10-09) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-10-09) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-10-12) - AA
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-10-09) - AP03
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-07) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2014-04-24) - AP03
-
termination-secretary-company-with-name (2014-04-24) - TM02
-
capital-allotment-shares (2014-01-22) - SH01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-09-23) - NEWINC
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2013-10-08) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-10-04) - AP01