-
SELF-STORAGE PERFORMANCE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED - 31 Wellington Road, Nantwich, Cheshire, CW5 7ED, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08696351
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 31 Wellington Road
- Nantwich
- Cheshire
- CW5 7ED 31 Wellington Road, Nantwich, Cheshire, CW5 7ED UK
Management
- Geschäftsführung
- FAHEY, Paul Anthony
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 18.09.2013
- Alter der Firma 2013-09-18 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70229
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mrs Angela Fahey
- Mr Paul Anthony Fahey
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- FORCEFIELD LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-06-30
- Letzte Einreichung: 2022-09-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2023-10-30
- Letzte Einreichung: 2022-10-16
-
SELF-STORAGE PERFORMANCE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED Firmenbeschreibung
- SELF-STORAGE PERFORMANCE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08696351. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 18.09.2013 registriert. SELF-STORAGE PERFORMANCE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen FORCEFIELD LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70229" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.09.2022 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 31 Wellington Road erreicht werden.
Jetzt sichern SELF-STORAGE PERFORMANCE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Self-Storage Performance Management International Limited - 31 Wellington Road, Nantwich, Cheshire, CW5 7ED, Grossbritannien
- 2013-09-18
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu SELF-STORAGE PERFORMANCE MANAGEMENT INTERNATIONAL LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2023
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2023-05-16) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2022-05-20) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2022-06-13) - MR04
-
confirmation-statement-with-updates (2022-11-15) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2022-06-15) - MR01
-
second-filing-of-confirmation-statement-with-made-up-date (2022-08-17) - RP04CS01
keyboard_arrow_right 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-11-12) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-11-12) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-03-22) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-01) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-11-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-10) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-09) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-08) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2019-02-08) - PSC07
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-02-08) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-02-08) - TM02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-12-14) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-12-11) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-06-29) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-12) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-02) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-06-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-24) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-17) - CS01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-10-05) - MR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-09-05) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-29) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-05-12) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-10-13) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-06-19) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-01-10) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-10-21) - AP01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-22) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-11-12) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-12) - AP01
-
certificate-change-of-name-company (2013-10-23) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-10-23) - CONNOT
-
termination-director-company-with-name (2013-10-02) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-09-25) - AD01
-
incorporation-company (2013-09-18) - NEWINC