-
PIERCES SOLAR LIMITED - 5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, London, W1G 9DQ, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08662075
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street
- Cavendish Square
- London
- W1G 9DQ
- United Kingdom 5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, London, W1G 9DQ, United Kingdom UK
Management
- Geschäftsführung
- CORAZZA, Enrico
- VAUGHAN, Sulwen
- Prokuristen
- LAGGAN SECRETARIES LIMITED
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 23.08.2013
- Alter der Firma 2013-08-23 11 Jahre
- SIC/NACE
- 35110
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- -
- Nextenergy Solar Holdings Iii Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Ehemalige Namen
- ANESCO ASSET MANAGEMENT SEVEN LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-12-31
- Letzte Einreichung: 2023-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-09-14
- Letzte Einreichung: 2023-08-31
-
PIERCES SOLAR LIMITED Firmenbeschreibung
- PIERCES SOLAR LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08662075. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 23.08.2013 registriert. PIERCES SOLAR LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen ANESCO ASSET MANAGEMENT SEVEN LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "35110" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 5Th Floor North Side, 7/10 Chandos Street erreicht werden.
Jetzt sichern PIERCES SOLAR LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Pierces Solar Limited - 5th Floor North Side, 7/10 Chandos Street, Cavendish Square, London, W1G 9DQ, Grossbritannien
- 2013-08-23
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PIERCES SOLAR LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2024-09-04) - AD01
keyboard_arrow_right 2023
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-09-06) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2023-12-16) - AA
keyboard_arrow_right 2022
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2022-01-24) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2022-01-24) - PSC02
-
confirmation-statement-with-updates (2022-01-24) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2022-09-07) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2022-12-28) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-02-03) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-27) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-10-07) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-08-28) - CH01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-05-19) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2020-03-02) - PSC05
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-28) - CH01
-
change-person-director-company-with-change-date (2020-02-27) - CH01
keyboard_arrow_right 2019
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-09) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-03-21) - MR04
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-05-29) - AD01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC07
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-05-29) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-05-29) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-03-08) - AA
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2018-05-29) - TM02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-05-29) - PSC02
-
appoint-corporate-secretary-company-with-name-date (2018-09-19) - AP04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-09-19) - CS01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2018-10-23) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-07-31) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-06-30) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2016-05-27) - AA01
keyboard_arrow_right 2015
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2015-04-10) - TM01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-04-10) - TM02
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-13) - AP01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-04-13) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-04-13) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-04-14) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2015-06-04) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-06-16) - MR01
-
resolution (2015-06-25) - RESOLUTIONS
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-11-26) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-09) - AR01
-
certificate-change-of-name-company (2014-05-23) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-08-23) - NEWINC