-
PRIVILEGE PROJECT FINANCE 2 LIMITED - 4th Floor, 36 Spital Square, London, E1 6DY, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08656234
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 4th Floor, 36 Spital Square
- London
- E1 6DY 4th Floor, 36 Spital Square, London, E1 6DY UK
Management
- Geschäftsführung
- VERNAU, Andrew Michael
- WINWARD, Christopher Paul
- GILES, Tracy Jane
- Prokuristen
- MAY, Graham Philip
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 19.08.2013
- Alter der Firma 2013-08-19 10 Jahre
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Privilege Holdings 2 Limited
- -
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- PRIVILEGE EQUIPMENT FINANCE 2 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-09-30
- Letzte Einreichung: 2020-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-02
- Letzte Einreichung: 2021-08-19
-
PRIVILEGE PROJECT FINANCE 2 LIMITED Firmenbeschreibung
- PRIVILEGE PROJECT FINANCE 2 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08656234. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 19.08.2013 registriert. PRIVILEGE PROJECT FINANCE 2 LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen PRIVILEGE EQUIPMENT FINANCE 2 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer und 1 Prokuristen.Die Firma kann schriftlich über 4Th Floor, 36 Spital Square erreicht werden.
Jetzt sichern PRIVILEGE PROJECT FINANCE 2 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Privilege Project Finance 2 Limited - 4th Floor, 36 Spital Square, London, E1 6DY, Grossbritannien
- 2013-08-19
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu PRIVILEGE PROJECT FINANCE 2 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-08-19) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-05-24) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-07-11) - AA
keyboard_arrow_right 2020
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-01-27) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2020-06-24) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-21) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-09-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-23) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-05-08) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-08-24) - PSC02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-17) - AA
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-08-24) - PSC07
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-24) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-09-27) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-27) - PSC02
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2018-10-10) - MR01
keyboard_arrow_right 2017
-
resolution (2017-12-22) - RESOLUTIONS
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-06) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-10-04) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-13) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-10-10) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-02-24) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-23) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2015
-
certificate-change-of-name-company (2015-12-24) - CERTNM
-
auditors-resignation-company (2015-09-02) - AUD
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-10-29) - AA01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2015-01-07) - AD01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2015-01-07) - AP03
-
change-person-director-company-with-change-date (2015-03-02) - CH01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2015-01-07) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-small (2015-04-15) - AA
-
auditors-resignation-company (2015-08-20) - AUD
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-24) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-03-18) - AA01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-18) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-12-18) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-10-21) - AR01
-
change-person-secretary-company-with-change-date (2014-10-21) - CH03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-10-21) - AD01
keyboard_arrow_right 2013
-
termination-director-company-with-name (2013-09-19) - TM01
-
incorporation-company (2013-08-19) - NEWINC