-
CAVENDISH CONTINENTAL ENGINEERING LTD - Unit 5 Avening Road, Nailsworth, Stroud, Gloucestershire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08650117
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Unit 5 Avening Road
- Nailsworth
- Stroud
- Gloucestershire
- GL6 0BS
- England Unit 5 Avening Road, Nailsworth, Stroud, Gloucestershire, GL6 0BS, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HARRIS, Conrad James Wardley
- Prokuristen
- HARRIS, Conrad James Wardley
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 14.08.2013
- Alter der Firma 2013-08-14 10 Jahre
- SIC/NACE
- 45200
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Conrad James Wardley Harris
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-05-31
- Letzte Einreichung: 2018-08-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-09-25
- Letzte Einreichung: 2019-08-14
-
CAVENDISH CONTINENTAL ENGINEERING LTD Firmenbeschreibung
- CAVENDISH CONTINENTAL ENGINEERING LTD ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08650117. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 14.08.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "45200" registriert. Das Unternehmen hat 1 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 31.08.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Unit 5 Avening Road erreicht werden.
Jetzt sichern CAVENDISH CONTINENTAL ENGINEERING LTD HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Cavendish Continental Engineering Ltd - Unit 5 Avening Road, Nailsworth, Stroud, Gloucestershire, Grossbritannien
- 2013-08-14
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CAVENDISH CONTINENTAL ENGINEERING LTD aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-06-17) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-03-26) - AD01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-09-02) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-17) - DISS40
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-08-14) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-07-30) - GAZ1
keyboard_arrow_right 2018
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-11-29) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-16) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-08-21) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-05-30) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-31) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-25) - CS01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-20) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-05-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-08) - AR01
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2014-09-08) - AP03
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-09-08) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-09-08) - TM02
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-08-14) - NEWINC