-
NEW SHORE DEVELOPMENTS LIMITED - 21 Church Road, Poole, Dorset, BH14 8UF, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08622209
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 21 Church Road
- Poole
- Dorset
- BH14 8UF 21 Church Road, Poole, Dorset, BH14 8UF UK
Management
- Geschäftsführung
- LOWE, Timothy James
- MAULLIN, Timothy Nigel
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 24.07.2013
- Gelöscht am:
- 2022-09-15
- SIC/NACE
- 41100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Mr Tim Maullin
- Mr Timothy Nigel Maullin
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2018-12-31
- Letzte Einreichung: 2017-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-07
- Letzte Einreichung: 2019-07-24
-
NEW SHORE DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- NEW SHORE DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08622209. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 24.07.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "41100" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über 21 Church Road erreicht werden.
Jetzt sichern NEW SHORE DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: New Shore Developments Limited - 21 Church Road, Poole, Dorset, BH14 8UF, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NEW SHORE DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-affairs (2020-02-12) - LIQ02
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2020-01-11) - DISS40
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2020-02-12) - 600
-
resolution (2020-02-12) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
gazette-notice-compulsory (2019-12-31) - GAZ1
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-08-28) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2019-08-28) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2019-08-24) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2019-08-21) - CS01
-
gazette-notice-compulsory (2019-08-20) - GAZ1
-
capital-allotment-shares (2019-01-23) - SH01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-02-22) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-22) - PSC04
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-02-23) - PSC04
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-04-16) - PSC07
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-04-17) - PSC04
-
change-person-director-company-with-change-date (2018-08-24) - CH01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2018-08-24) - PSC04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-08-01) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-22) - MR04
-
resolution (2017-10-11) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-25) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2017-07-21) - PSC04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-06-01) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-06-01) - AA01
-
capital-allotment-shares (2017-05-04) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2017-04-28) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-08-29) - TM01
keyboard_arrow_right 2016
-
gazette-notice-compulsory (2016-07-05) - GAZ1
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-07-13) - AD01
-
change-person-director-company-with-change-date (2016-08-08) - CH01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2016-08-09) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-08) - CS01
-
accounts-amended-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-09-15) - AAMD
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2016-11-04) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-08-31) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-08-28) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-08-28) - AA
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-05-23) - MR01
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-08-20) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-21) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2014-02-15) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-07-24) - NEWINC