-
VYPR VALIDATION TECHNOLOGIES LIMITED - Suite 02-120 29 John Dalton Street, Manchester, M2 6FW, England, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08589377
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Suite 02-120 29 John Dalton Street
- Manchester
- M2 6FW
- England Suite 02-120 29 John Dalton Street, Manchester, M2 6FW, England UK
Management
- Geschäftsführung
- DAVIES, Benjamin Charles
- LAW, Richard Anthony
- YOUNG, Richard Michael
- BALDWIN, Kevin John
- FREED, Daniel Simon
- THORNTON, Richard Michael
- WILLIAMS, Chris
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 28.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-28 10 Jahre
- SIC/NACE
- 63990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- SOPROVAL LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2022-12-31
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
- lezte Bilanzhinterlegung
- 2015-06-28
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-09-08
- Letzte Einreichung: 2021-08-25
-
VYPR VALIDATION TECHNOLOGIES LIMITED Firmenbeschreibung
- VYPR VALIDATION TECHNOLOGIES LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08589377. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 28.06.2013 registriert. VYPR VALIDATION TECHNOLOGIES LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen SOPROVAL LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "63990" registriert. Das Unternehmen hat 7 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2014 hinterlegt. Die jährliche Meldung erfolgte zuletzt am 28.06.2015.Die Firma kann schriftlich über Suite 02-120 29 John Dalton Street erreicht werden.
Jetzt sichern VYPR VALIDATION TECHNOLOGIES LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Vypr Validation Technologies Limited - Suite 02-120 29 John Dalton Street, Manchester, M2 6FW, England, Grossbritannien
- 2013-06-28
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu VYPR VALIDATION TECHNOLOGIES LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-03-14) - AD01
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-12-19) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-07) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-12-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2021-08-31) - CS01
-
capital-allotment-shares (2021-04-07) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-24) - AP01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-03-25) - AP01
-
resolution (2021-01-28) - RESOLUTIONS
-
capital-name-of-class-of-shares (2021-01-19) - SH08
-
capital-allotment-shares (2021-01-18) - SH01
-
memorandum-articles (2021-01-28) - MA
keyboard_arrow_right 2020
-
resolution (2020-07-10) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2020-02-27) - SH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2020-01-31) - AD01
-
legacy (2020-07-10) - SH20
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2020-07-10) - SH19
-
legacy (2020-07-10) - CAP-SS
-
mortgage-satisfy-charge-full (2020-04-29) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-08-04) - AA
-
resolution (2020-09-09) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2020-07-27) - MR01
-
resolution (2020-07-14) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2020-12-11) - CS01
-
capital-allotment-shares (2020-09-28) - SH01
-
resolution (2020-03-04) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2019
-
notification-of-a-person-with-significant-control-statement (2019-04-12) - PSC08
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2019-04-30) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-05-10) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-08) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2019-09-30) - TM01
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-micro-entity (2018-05-02) - AA
-
capital-allotment-shares (2018-10-09) - SH01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-03) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-03-09) - AD01
-
resolution (2018-10-12) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2018-10-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-12-01) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-10-10) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2017-10-09) - PSC07
-
resolution (2017-09-14) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2017-09-07) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-05-11) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2017-04-06) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-03-06) - MR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2017-02-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2016
-
capital-allotment-shares (2016-09-26) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2016-12-09) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-09-23) - AP01
-
resolution (2016-09-18) - RESOLUTIONS
-
confirmation-statement-with-updates (2016-08-25) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-03-30) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2016-09-16) - SH08
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-22) - AR01
-
capital-allotment-shares (2015-06-18) - SH01
-
resolution (2015-06-18) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2015-05-30) - SH01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-03-27) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
capital-allotment-shares (2014-11-25) - SH01
-
certificate-change-of-name-company (2014-11-24) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2014-11-24) - CONNOT
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-09-11) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-11-04) - AP01
-
incorporation-company (2013-06-28) - NEWINC
-
appoint-person-secretary-company-with-name (2013-11-04) - AP03
-
resolution (2013-11-11) - RESOLUTIONS
-
capital-allotment-shares (2013-11-15) - SH01
-
capital-allotment-shares (2013-11-11) - SH01
-
capital-alter-shares-subdivision (2013-11-11) - SH02