-
GREENSWITCH DEVELOPMENTS LIMITED - Kpmg Llp One Snowhill, Now Hill Queensway, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08587423
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Kpmg Llp One Snowhill
- Now Hill Queensway
- Birmingham
- West Midlands
- B4 6GH Kpmg Llp One Snowhill, Now Hill Queensway, Birmingham, West Midlands, B4 6GH UK
Management
- Geschäftsführung
- BILLINGHAM, Mark
- CHATHAM, Alan
- Prokuristen
- ROWBOTTOM, Peter Graham
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 27.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-27 10 Jahre
- SIC/NACE
- 71129
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Alan Chatham
- Mr Mark Billingham
- Mr Alan Chatham
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- liquidation
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2020-03-31
- Letzte Einreichung: 2018-06-30
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2020-08-08
- Letzte Einreichung: 2019-06-27
-
GREENSWITCH DEVELOPMENTS LIMITED Firmenbeschreibung
- GREENSWITCH DEVELOPMENTS LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08587423. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 27.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71129" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer und 1 Prokuristen. Die Bilanz wurde zuletzt am 30.06.2018 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Kpmg Llp One Snowhill erreicht werden.
Jetzt sichern GREENSWITCH DEVELOPMENTS LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Greenswitch Developments Limited - Kpmg Llp One Snowhill, Now Hill Queensway, Birmingham, West Midlands, Grossbritannien
- 2013-06-27
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu GREENSWITCH DEVELOPMENTS LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-voluntary-resignation-liquidator (2021-08-07) - LIQ06
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2021-08-07) - 600
keyboard_arrow_right 2020
-
liquidation-voluntary-statement-of-receipts-and-payments-with-brought-down-date (2020-10-16) - LIQ03
keyboard_arrow_right 2019
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-08-28) - AD01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-06-28) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-22) - MR04
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-03-21) - AA
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-08-27) - 600
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-08-27) - LIQ01
-
resolution (2019-08-27) - RESOLUTIONS
keyboard_arrow_right 2018
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-04-23) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-charge-whole-cease-and-release-with-charge-number (2017-08-02) - MR05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-06-29) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-29) - PSC01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-03-14) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-secretary-company-with-name-date (2016-08-18) - AP03
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-07-15) - AR01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-02-24) - TM01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-23) - AD01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-01-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-04-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-21) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-04-13) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2014-01-16) - AD01
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2014-05-16) - MR05
-
mortgage-charge-part-both-with-charge-number (2014-07-09) - MR05
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-09-09) - MR01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-21) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-24) - AD01
-
capital-allotment-shares (2013-07-16) - SH01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-16) - AP01
-
resolution (2013-07-16) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-07-12) - MR01
-
incorporation-company (2013-06-27) - NEWINC