-
NORTECH SOLUTIONS GROUP LIMITED - Nijhuis Industries Uk & Ireland Unit 4, Blenheim Court, Woodlands, Bradley Stoke, Bristol, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08586156
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Nijhuis Industries Uk & Ireland Unit 4, Blenheim Court
- Woodlands
- Bradley Stoke
- Bristol
- BS32 4NE
- England Nijhuis Industries Uk & Ireland Unit 4, Blenheim Court, Woodlands, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4NE, England UK
Management
- Geschäftsführung
- HOLTERMAN, Menno-Martijn
- STENTIFORD, Ian Mark
- RUIJTENBERG, Antonie
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-26 10 Jahre
- SIC/NACE
- 71121
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- Nijhuis Industries Holding B.V.
- Nijhuis Saur Industries Uk & Ireland Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- Active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2024-09-30
- Letzte Einreichung: 2022-12-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2024-07-10
- Letzte Einreichung: 2023-06-26
-
NORTECH SOLUTIONS GROUP LIMITED Firmenbeschreibung
- NORTECH SOLUTIONS GROUP LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08586156. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "71121" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.03.2021 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über Nijhuis Industries Uk & Ireland Unit 4, Blenheim Court erreicht werden.
Jetzt sichern NORTECH SOLUTIONS GROUP LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Nortech Solutions Group Limited - Nijhuis Industries Uk & Ireland Unit 4, Blenheim Court, Woodlands, Bradley Stoke, Bristol, Grossbritannien
- 2013-06-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu NORTECH SOLUTIONS GROUP LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2024
-
capital-alter-shares-subdivision (2024-01-25) - SH02
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2024-01-19) - PSC02
keyboard_arrow_right 2023
-
accounts-with-accounts-type-small (2023-10-13) - AA
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2023-10-10) - DISS40
-
gazette-notice-compulsory (2023-09-12) - GAZ1
-
confirmation-statement-with-no-updates (2023-10-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2022
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2022-01-12) - AD01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2022-01-12) - AA01
-
gazette-filings-brought-up-to-date (2022-10-01) - DISS40
-
confirmation-statement-with-updates (2022-09-30) - CS01
-
change-person-director-company-with-change-date (2022-09-30) - CH01
-
gazette-notice-compulsory (2022-09-20) - GAZ1
-
accounts-with-accounts-type-small (2022-12-22) - AA
keyboard_arrow_right 2021
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2021-05-19) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-10-27) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2021-10-27) - AP01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-07-13) - CS01
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2021-10-27) - PSC07
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2021-10-27) - PSC02
keyboard_arrow_right 2020
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2020-07-21) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-08-28) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2019-12-16) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-30) - CS01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-08-14) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-08-16) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-09-17) - PSC01
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-07-31) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-12-06) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-02-22) - AD01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-08-01) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-12-21) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-08-04) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-02) - AR01
keyboard_arrow_right 2014
-
accounts-with-accounts-type-group (2014-12-05) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-01) - AR01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-04-09) - AA01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-04-04) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-11-06) - MR01
-
capital-allotment-shares (2013-09-19) - SH01
-
incorporation-company (2013-06-26) - NEWINC