-
CLEARVIEW HOME IMPROVEMENTS (HOLDINGS) LIMITED - 5 Peregrine Place, Moss Side, Leyland, Lancashire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08586133
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 5 Peregrine Place
- Moss Side
- Leyland
- Lancashire
- PR25 3EY 5 Peregrine Place, Moss Side, Leyland, Lancashire, PR25 3EY UK
Management
- Geschäftsführung
- GISCOMBE, Michael Alexander
- KANE, Gregory
- VAN HAAZEL, Sarah Lyn
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 26.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-26 10 Jahre
- SIC/NACE
- 70100
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- -
- -
- Conservatory Outlet Group Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-05-31
- Letzte Einreichung: 2019-05-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-07-10
- Letzte Einreichung: 2020-06-26
-
CLEARVIEW HOME IMPROVEMENTS (HOLDINGS) LIMITED Firmenbeschreibung
- CLEARVIEW HOME IMPROVEMENTS (HOLDINGS) LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08586133. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 26.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "70100" registriert. Das Unternehmen hat 3 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.05.2019 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 5 Peregrine Place erreicht werden.
Jetzt sichern CLEARVIEW HOME IMPROVEMENTS (HOLDINGS) LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Clearview Home Improvements (Holdings) Limited - 5 Peregrine Place, Moss Side, Leyland, Lancashire, Grossbritannien
- 2013-06-26
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CLEARVIEW HOME IMPROVEMENTS (HOLDINGS) LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
legacy (2021-06-09) - GUARANTEE2
-
legacy (2021-06-09) - AGREEMENT2
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2021-05-17) - AA01
keyboard_arrow_right 2020
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2020-06-29) - AD03
-
change-sail-address-company-with-old-address-new-address (2020-06-29) - AD02
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-07-03) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-12-27) - AA
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-07-23) - MR04
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2019-07-23) - MR01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-07-05) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-small (2019-01-16) - AA
keyboard_arrow_right 2018
-
cessation-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC07
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2018-03-08) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-small (2018-03-19) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2018-03-21) - PSC02
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2018-05-16) - AA01
-
move-registers-to-registered-office-company-with-new-address (2018-07-03) - AD04
-
confirmation-statement-with-updates (2018-07-03) - CS01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2018-07-03) - AA01
keyboard_arrow_right 2017
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2017-07-25) - TM02
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-25) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-07-25) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-07-26) - TM01
-
resolution (2017-07-10) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2017-07-07) - MR01
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-28) - CS01
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-06-28) - PSC01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2017-06-12) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2017-06-09) - AD02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-04-12) - AA
-
capital-name-of-class-of-shares (2017-07-11) - SH08
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2016-05-17) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2015-07-08) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-07-02) - AR01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2015-10-23) - MR04
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-02) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-06-19) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-small (2014-05-20) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name (2014-03-03) - AP01
-
capital-name-of-class-of-shares (2014-02-24) - SH08
-
resolution (2014-02-24) - RESOLUTIONS
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2014-02-10) - AA01
keyboard_arrow_right 2013
-
incorporation-company (2013-06-26) - NEWINC
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-22) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-08-09) - MR01
-
capital-allotment-shares (2013-08-30) - SH01