-
EHE 4 LIMITED - 7th Floor Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08580128
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- 7th Floor Dashwood House
- 69 Old Broad Street
- London
- EC2M 1QS 7th Floor Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS UK
Management
- Geschäftsführung
- COETZEE, Russell Steven
- CONWAY, Eoin Harry
- QUAYLE, Clifford Anthony
- ROBERTS, David Ian
- Prokuristen
- -
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 21.06.2013
- Gelöscht am:
- 2020-06-09
- SIC/NACE
- 99999
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Edinburgh House Estates (Holdings) Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit:
- Letzte Einreichung: 2017-12-31
-
EHE 4 LIMITED Firmenbeschreibung
- EHE 4 LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08580128. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 21.06.2013 registriert. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "99999" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Bilanz wurde zuletzt am 31.12.2017 hinterlegt.Die Firma kann schriftlich über 7Th Floor Dashwood House erreicht werden.
Jetzt sichern EHE 4 LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Ehe 4 Limited - 7th Floor Dashwood House, 69 Old Broad Street, London, EC2M 1QS, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu EHE 4 LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2020
-
gazette-dissolved-liquidation (2020-06-09) - GAZ2
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-01-10) - CS01
-
liquidation-voluntary-members-return-of-final-meeting (2020-03-09) - LIQ13
keyboard_arrow_right 2019
-
liquidation-voluntary-declaration-of-solvency (2019-03-16) - LIQ01
-
liquidation-voluntary-appointment-of-liquidator (2019-03-16) - 600
-
resolution (2019-03-16) - RESOLUTIONS
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-02-14) - PSC05
-
confirmation-statement-with-no-updates (2019-01-11) - CS01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-03-18) - AD01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2019-01-08) - AD01
keyboard_arrow_right 2018
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2018-01-08) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2018-10-02) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-06-11) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2018-02-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2018-02-09) - TM01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-01-10) - CS01
keyboard_arrow_right 2017
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2017-10-04) - AA
-
confirmation-statement-with-updates (2017-01-09) - CS01
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-10-11) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2016-08-25) - AA
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-08-05) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-06-09) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-03-30) - TM01
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-01-08) - AR01
keyboard_arrow_right 2015
-
accounts-with-accounts-type-dormant (2015-10-09) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-23) - AR01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2015-03-13) - AP01
keyboard_arrow_right 2014
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-22) - AP01
-
termination-secretary-company-with-name-termination-date (2014-12-22) - TM02
-
accounts-with-accounts-type-total-exemption-full (2014-10-03) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-27) - AR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-06-27) - AA01
-
incorporation-company (2013-06-21) - NEWINC