-
33 DOVER ST LIMITED - Bridgeway House, Bridgeway, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08566560
- Firmenstatus
- EINGETRAGEN
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- Bridgeway House
- Bridgeway
- Stratford-Upon-Avon
- Warwickshire
- CV37 6YX
- England Bridgeway House, Bridgeway, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, CV37 6YX, England UK
Management
- Geschäftsführung
- MURRAY, Michael
- RIGBY, James Peter
- RIGBY, Peter, Sir
- RIGBY, Steven Paul
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 12.06.2013
- Alter der Firma 2013-06-12 10 Jahre
- SIC/NACE
- 82990
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Rigby Group (Rg) Plc
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- active
- Ehemalige Namen
- RIGBY GROUP PROPERTY HOLDINGS LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-12-31
- Letzte Einreichung: 2020-03-31
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2022-04-14
- Letzte Einreichung: 2021-03-31
-
33 DOVER ST LIMITED Firmenbeschreibung
- 33 DOVER ST LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08566560. Ihr derzeitiger Status ist "eingetragen". Die Firma wurde 12.06.2013 registriert. 33 DOVER ST LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen RIGBY GROUP PROPERTY HOLDINGS LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "82990" registriert. Das Unternehmen hat 4 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über Bridgeway House erreicht werden.
Jetzt sichern 33 DOVER ST LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: 33 Dover St Limited - Bridgeway House, Bridgeway, Stratford-Upon-Avon, Warwickshire, Grossbritannien
- 2013-06-12
- 0-2
- 3-5
- 6-20
- 21-50
- 51+
- Jahre
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu 33 DOVER ST LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2021-09-01) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-small (2021-01-07) - AA
-
confirmation-statement-with-no-updates (2021-03-31) - CS01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2021-06-24) - MR04
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-09-30) - CS01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2020-08-03) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2020-02-12) - TM01
keyboard_arrow_right 2019
-
resolution (2019-01-25) - RESOLUTIONS
-
capital-statement-capital-company-with-date-currency-figure (2019-01-25) - SH19
-
legacy (2019-01-25) - SH20
-
mortgage-satisfy-charge-full (2019-01-30) - MR04
-
legacy (2019-01-25) - CAP-SS
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-03) - AP01
-
confirmation-statement-with-updates (2019-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-11-04) - AA
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2019-04-02) - AP01
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-10-03) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-12-18) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
mortgage-satisfy-charge-full (2017-11-09) - MR04
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-10-02) - CS01
-
confirmation-statement-with-no-updates (2017-09-30) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-08-18) - AA
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2016
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-15) - AR01
-
confirmation-statement-with-updates (2016-10-03) - CS01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2016-09-30) - AD03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-08-17) - AD01
-
accounts-with-accounts-type-group (2016-01-07) - AA
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-16) - AR01
-
move-registers-to-sail-company-with-new-address (2015-06-16) - AD03
-
change-sail-address-company-with-new-address (2015-06-16) - AD02
-
capital-allotment-shares (2015-05-14) - SH01
-
resolution (2015-05-14) - RESOLUTIONS
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2015-02-07) - MR01
-
accounts-with-accounts-type-group (2015-01-06) - AA
-
certificate-change-of-name-company (2015-09-18) - CERTNM
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-07-09) - AR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-22) - MR01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number-charge-creation-date (2014-10-29) - MR01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-of-name-notice (2013-07-18) - CONNOT
-
certificate-change-of-name-company (2013-07-18) - CERTNM
-
resolution (2013-07-22) - RESOLUTIONS
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-30) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-30) - TM01
-
change-account-reference-date-company-current-shortened (2013-07-30) - AA01
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-12-20) - MR01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-30) - AP01
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-08) - CH01
-
capital-allotment-shares (2013-09-12) - SH01
-
incorporation-company (2013-06-12) - NEWINC