-
CHICAGO LEISURE LIMITED - C/O Bdo Llp Two Snowhill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
Firmenprofil
- Handelsregisternummer
- 08561431
- Firmenstatus
- GELÖSCHT
- Land
- Grossbritannien
- Protokollierter Sitz
- C/O Bdo Llp Two Snowhill
- Snow Hill Queensway
- Birmingham
- B4 6GA C/O Bdo Llp Two Snowhill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA UK
Management
- Geschäftsführung
- MARKS, Peter Jack
- MILLINGTON, Alex
Firmendetails
- Geschäftszweig
- ltd
- Gründungsdatum
- 07.06.2013
- Gelöscht am:
- 2022-03-22
- SIC/NACE
- 56101
Eigentumsverhältnisse
- Beneficial Owners
- Mr Paul John Evans
- The Executors Of The Estate Of The Late Paul John Evans
- Deltic Chicago's Limited
Landes-Besonderheiten
- Zusätzliche Statusdetails
- dissolved
- Ehemalige Namen
- TOPAZ BIDCO 1 LIMITED
- Bilanzhinterlegung
- Fälligkeit: 2021-02-28
- Letzte Einreichung: 2019-02-23
- Jahresmeldung
- Fälligkeit: 2021-06-21
- Letzte Einreichung: 2020-06-07
-
CHICAGO LEISURE LIMITED Firmenbeschreibung
- CHICAGO LEISURE LIMITED ist eine in Grossbritannien als ltd registrierte Firma mit der Register-Nr. 08561431. Ihr derzeitiger Status ist "gelöscht". Die Firma wurde 07.06.2013 registriert. CHICAGO LEISURE LIMITED hat Ihre Tätigkeit zuvor unter dem Namen TOPAZ BIDCO 1 LIMITED ausgeführt. Das Unternehmen ist mit dem SIC/NACE Code "56101" registriert. Das Unternehmen hat 2 Geschäftsführer Die Firma kann schriftlich über C/o Bdo Llp Two Snowhill erreicht werden.
Jetzt sichern CHICAGO LEISURE LIMITED HandelsregisterauszugJahresabschlussListe der GesellschafterGesellschaftsvertragBeneficial Owners Check
Sie befinden sich hier: Chicago Leisure Limited - C/O Bdo Llp Two Snowhill, Snow Hill Queensway, Birmingham, B4 6GA, Grossbritannien
Haben Sie gewusst? kompany stellt Ihnen amtliche & offizielle Dokumente zu CHICAGO LEISURE LIMITED aus Handelsregister und Firmenbuch im Original zur Verfügung. Das garantieren wir.
Handelsregisterauszug
Amtlicher Nachweis der Existenz des Unternehmens
Jahresabschluss
Finanzdaten zum letzten Berichtsjahr
Liste der Gesellschafter
Angaben zu den Eigentumsverhältnissen
Gesellschaftsvertrag
Gründungsdokumente
Beneficial Owners Check
Angaben über den wirtschaftlichen Eigentümer (Beneficial Owner)
Amtliche Dokumente
Amtliche Dokumente direkt vom offiziellen Handelsregister
keyboard_arrow_down 2021
-
liquidation-in-administration-move-to-dissolution (2021-12-22) - AM23
-
liquidation-in-administration-appointment-of-administrator (2021-01-06) - AM01
-
liquidation-in-administration-proposals (2021-01-06) - AM03
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-20) - AD01
-
liquidation-in-administration-statement-of-affairs-with-form-attached (2021-11-25) - AM02
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2021-01-26) - AD01
-
liquidation-in-administration-progress-report (2021-07-29) - AM10
-
liquidation-in-administration-result-creditors-meeting (2021-01-21) - AM07
keyboard_arrow_right 2020
-
confirmation-statement-with-no-updates (2020-06-08) - CS01
keyboard_arrow_right 2019
-
accounts-with-accounts-type-full (2019-12-02) - AA
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-10) - PSC05
-
confirmation-statement-with-updates (2019-06-07) - CS01
-
change-to-a-person-with-significant-control (2019-06-07) - PSC05
keyboard_arrow_right 2018
-
confirmation-statement-with-no-updates (2018-06-08) - CS01
-
accounts-with-accounts-type-full (2018-08-15) - AA
keyboard_arrow_right 2017
-
confirmation-statement-with-updates (2017-06-19) - CS01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2017-03-02) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2017-03-02) - AP01
-
accounts-with-accounts-type-full (2017-12-06) - AA
-
notification-of-a-person-with-significant-control (2017-11-21) - PSC02
keyboard_arrow_right 2016
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2016-12-21) - AP01
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2016-12-21) - TM01
-
accounts-with-accounts-type-full (2016-09-01) - AA
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2016-06-29) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2016-01-06) - AD01
keyboard_arrow_right 2015
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2015-06-24) - AR01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-06-06) - AA
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-04-08) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-extended (2015-02-26) - AA01
-
change-account-reference-date-company-current-extended (2015-02-26) - AA01
-
change-account-reference-date-company-previous-shortened (2015-02-18) - AA01
-
accounts-with-accounts-type-full (2015-05-22) - AA
keyboard_arrow_right 2014
-
annual-return-company-with-made-up-date-full-list-shareholders (2014-06-25) - AR01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address-new-address (2014-12-04) - AD01
-
mortgage-satisfy-charge-full (2014-12-13) - MR04
-
termination-director-company-with-name-termination-date (2014-11-21) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name-date (2014-12-23) - AP01
keyboard_arrow_right 2013
-
change-person-director-company-with-change-date (2013-08-07) - CH01
-
change-registered-office-address-company-with-date-old-address (2013-07-03) - AD01
-
termination-director-company-with-name (2013-07-03) - TM01
-
appoint-person-director-company-with-name (2013-07-03) - AP01
-
legacy (2013-06-29) - MG06
-
certificate-change-of-name-company (2013-06-27) - CERTNM
-
change-of-name-notice (2013-06-27) - CONNOT
-
legacy (2013-06-27) - MG06
-
mortgage-create-with-deed-with-charge-number (2013-06-22) - MR01
-
incorporation-company (2013-06-07) - NEWINC